+ All Categories
Home > Documents > The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette...

The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette...

Date post: 22-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
41
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 170 Wednesday, July 11, 2012 / Le mercredi 11 juillet 2012 1117 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. JUNE 7, 2012 2012-203 Under section 3 of the New Brunswick Regulation 95-122, the General Regulation - Agricultural Insurance Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints or reappoints, as the case may be, the following persons as members of the New Brunswick Agricultural Insurance Commission, for a term of three years, effective June 7, 2012: (a) reappoints Léopold Bourgeois, Cocagne, New Bruns- wick, as Chairperson; (b) reappoints Gailen Allan, Glassville, New Brunswick, as Vice-Chairperson; Orders in Council Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. LE 7 JUIN 2012 2012-203 En vertu de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-122, Règlement général - Loi sur l’assurance agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme ou nomme pour un nouveau mandat, selon le cas, les personnes suivantes membres de la Commission de l’assurance agricole du Nouveau- Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 juin 2012 : a) nomme pour un nouveau mandat Léopold Bourgeois, de Cocagne (Nouveau-Brunswick), et le désigne président; b) nomme pour un nouveau mandat Gailen Allan, de Glassville (Nouveau-Brunswick), et le désigne vice- président; Décrets en conseil
Transcript
Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 170 Wednesday, July 11, 2012 / Le mercredi 11 juillet 2012 1117

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

JUNE 7, 20122012-203

Under section 3 of the New Brunswick Regulation 95-122, theGeneral Regulation - Agricultural Insurance Act, theLieutenant-Governor in Council appoints or reappoints, as thecase may be, the following persons as members of the NewBrunswick Agricultural Insurance Commission, for a term ofthree years, effective June 7, 2012:

(a) reappoints Léopold Bourgeois, Cocagne, New Bruns-wick, as Chairperson;(b) reappoints Gailen Allan, Glassville, New Brunswick, as Vice-Chairperson;

Orders in Council

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

LE 7 JUIN 20122012-203

En vertu de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick95-122, Règlement général - Loi sur l’assurance agricole, lelieutenant-gouverneur en conseil nomme ou nomme pour unnouveau mandat, selon le cas, les personnes suivantes membresde la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 7 juin2012 :

a) nomme pour un nouveau mandat Léopold Bourgeois, deCocagne (Nouveau-Brunswick), et le désigne président;b) nomme pour un nouveau mandat Gailen Allan, deGlassville (Nouveau-Brunswick), et le désigne vice-président;

Décrets en conseil

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1118 Gazette royale — 11 juillet 2012

(c) reappoints John Robinson Jr., Sussex, New Brunswick;

(d) appoints Mark DeMerchant, Tilley, New Brunswick;

(e) appoints Fern Rioux, Grand Falls, New Brunswick;

(f) appoints Beth Hatt, St. George, New Brunswick; and

(g) appoints David DuPlessis, Douglas, New Brunswick.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 7, 20122012-204

Under section 6 of the Economic Development Act, theLieutenant-Governor in Council reappoints the following per-sons as members of the New Brunswick Industrial Develop-ment Board, effective June 11, 2012, for a term to expire June10, 2014:

(a) Bill Levesque, as Chair;(b) Robert MacLeod, as Vice-Chair;(c) Eric Beaulieu, and approves the appointment by theMinister of Economic Development of him as secretary;(d) Marc Léger;(e) Phil LePage;(f) Carolyn MacKay; and(g) Robert Rioux.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 7, 20122012-205

1. Under subparagraph 11(1)(d)(i)) of the Economic and SocialInclusion Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints orreappoints, as the case may be, the following persons as mem-bers of the Board of the Economic and Social Inclusion Corpo-ration, for a term of four years, effective June 17, 2012:

(a) appoints Francine Landry, Saint-Jacques, New Bruns-wick; and(b) reappoints Derek Oland, New River Beach, New Bruns-wick.

2. Under subparagraph 11(1)(d)(ii)) of the Economic and So-cial Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in Council appointsor reappoints, as the case may be, the following persons asmembers of the Board of the Economic and Social InclusionCorporation, for a term of four years, effective June 17, 2012:

(a) appoints July Synnott, Goodwin Mill, New Brunswick;and(b) reappoints Brenda Murphy, Grand Bay-Westfield, NewBrunswick.

c) nomme pour un nouveau mandat John Robinson fils, deSussex (Nouveau-Brunswick);d) nomme Mark DeMerchant, de Tilley (Nouveau-Brunswick);e) nomme Fern Rioux, de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick);f) nomme Beth Hatt, de St. George (Nouveau-Brunswick);etg) nomme David DuPlessis, de Douglas (Nouveau-Brunswick).

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

LE 7 JUIN 20122012-204

En vertu de l’article 6 de la Loi sur le développement écono-mique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nou-veau mandat les personnes suivantes membres du Conseil dudéveloppement industriel du Nouveau-Brunswick, à compterdu 11 juin 2012, pour un mandat prenant fin le 10 juin 2014 :

a) Bill Levesque, et le désigne président;b) Robert MacLeod, et le désigne vice-président;c) Éric Beaulieu, et approuve sa nomination à titre de se-crétaire par le ministre du Développement économique;d) Marc Léger;e) Phil LePage;f) Carolyn MacKay; etg) Robert Rioux.

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

LE 7 JUIN 20122012-205

1. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(i) de la Loi sur l’inclusionéconomique et sociale, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme ou nomme pour un nouveau mandat, selon le cas, lespersonnes suivantes membres du conseil de la Société d’inclu-sion économique et sociale, pour un mandat de quatre ans, àcompter du 17 juin 2012 :

a) nomme Francine Landry, de Saint-Jacques (Nouveau-Brunswick); etb) nomme pour un nouveau mandat Derek Oland, de NewRiver Beach (Nouveau-Brunswick).

2. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(ii) de la Loi sur l’inclusionéconomique et sociale, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme ou nomme pour un nouveau mandat, selon le cas, lespersonnes suivantes membres du conseil de la Société d’inclu-sion économique et sociale, pour un mandat de quatre ans, àcompter du 17 juin 2012 :

a) nomme July Synnott, de Goodwin Mill (Nouveau-Brunswick); etb) nomme pour un nouveau mandat Brenda Murphy, deGrand Bay-Westfield (Nouveau-Brunswick).

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012

3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and So-cial Inclusion Act, the Lieutenant-Governor in Council appointsor reappoints, as the case may be, the following persons asmembers of the Board of the Economic and Social InclusionCorporation, for a term of four years, effective June 17, 2012:

(a) appoints Angel Michaud, Perth-Andover, New Bruns-wick;(b) appoints Beverly Wilcox, Bathurst, New Brunswick;

(c) reappoints Ginette Arseneault, Fredericton, New Bruns-wick; and(d) reappoints Jacques-Francois Levesque, Grand Falls,New Brunswick.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 12, 20122012-211

Under sections 3, 4 and 6 of the Agricultural Operation Prac-tices Act, the Lieutenant-Governor in Council reappoints thefollowing persons as members of the Farm Practices ReviewBoard, effective June 12, 2012, for a term to expire March 22,2015:

(a) Maarten van Oord, Springfield, New Brunswick, desig-nated as Chair, recommended by a farm organization;

(b) Ken Reicker, Newline Cape, New Brunswick, recom-mended by a farm organization; and(c) Wilmot Smith, Somerville, New Brunswick, who doesnot carry on an agricultural operation.

Graydon Nicholas, Lieutenant-Governor

DECLARATIONIN THE MATTER OF THE

MUNICIPAL ELECTIONS ACTQUADRENNIAL MUNICIPAL AND

RURAL COMMUNITY, DISTRICT EDUCATIONCOUNCIL, AND REGIONAL HEALTH AUTHORITY

ELECTIONS, MAY 14, 2012Under subsection 41(5) of the Municipal Elections Act, I,Michael P. Quinn, Municipal Electoral Officer, do hereby de-clare the following candidates to be elected to the respective po-sitions indicated hereunder.

ElectionsNew Brunswick

3. En vertu du sous-alinéa 11(1)d)(iii) de la Loi sur l’inclusionéconomique et sociale, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme ou nomme pour un nouveau mandat, selon le cas, lespersonnes suivantes membres du conseil de la Société d’inclu-sion économique et sociale, pour un mandat de quatre ans, àcompter du 17 juin 2012 :

a) nomme Angel Michaud, de Perth-Andover (Nouveau-Brunswick);b) nomme Beverly Wilcox, de Bathurst (Nouveau-Brunswick);c) nomme pour un nouveau mandat Ginette Arseneault, deFredericton (Nouveau-Brunswick); etd) nomme pour un nouveau mandat Jacques-FrançoisLevesque, de Grand-Sault (Nouveau-Brunswick).

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

________________

LE 12 JUIN 20122012-211

En vertu des articles 3, 4 et 6 de la Loi sur les pratiques relativesaux opérations agricoles, le lieutenant-gouverneur en conseilnomme pour un nouveau mandat les personnes suivantesmembres de la Commission de révision des pratiques agricoles,à compter du 12 juin 2012, pour un mandat prenant fin le22 mars 2015 :

a) Maarten van Oord, de Springfield (Nouveau-Brunswick), à titre de membre recommandé par un orga-nisme agricole, et le désigne président;b) Ken Reicker, de Newline Cape (Nouveau-Brunswick), àtitre de membre recommandé par un organisme agricole; etc) Wilmot Smith, de Somerville (Nouveau-Brunswick), àtitre de membre n’exerçant aucune activité agricole.

Le lieutenant-gouverneur, Graydon Nicholas

DÉCLARATIONLOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

ÉLECTIONS QUADRIENNALES MUNICIPALES ET DE COMMUNAUTÉS

RURALES, DE CONSEILS D’ÉDUCATION DE DISTRICT ET DE RÉGIES RÉGIONALES

DE LA SANTÉ DU 14 MAI 2012En vertu du paragraphe 41(5) de la Loi sur les élections munici-pales, je, Michael P. Quinn, directeur des élections municipales,déclare les candidat(e)s suivant(e)s élu(e)s aux postes indiqués.

ÉlectionsNouveau-Brunswick

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1120 Gazette royale — 11 juillet 2012

MUNICIPAL AND RURAL COMMUNITY ELECTIONS

Municipality or Rural Community(incorporated name)

Name of Candidate Position

Alma, Village of Herta Kirstin Shortt MayorRyan H. Butland Councillor at LargeAndrew James Casey Councillor at LargeFred V. Hall Councillor at Large

Aroostook, Village of Marven C. Demmings MayorTina L. Lockhart Councillor at LargeEileen P. McLaughlin Councillor at LargeLynn Nunn Councillor at Large

Atholville, Village of Michel Soucy MayorBetty Cleveland Firth Councillor at LargeGaëtan Cormier Councillor at LargeGerard Fallu Councillor at LargeMaurice Power Councillor at LargeJean Soucy Councillor at Large

Baker-Brook (village) Francine Caron MayorEmilien Bonenfant Councillor at LargeJoan Levesque Councillor at LargeSuzanne Morneault Councillor at LargeJeannette Raymond Councillor at Large

Balmoral, Village of Charles Bernard MayorClaude F. Arseneault Councillor at LargeJean Paul Bélanger Councillor at LargeGuy J. Landry Councillor at LargeJosée (Dou Dou) Levesque

Councillor at Large

Donald Savoie Councillor at Large

Bas-Caraquet, Village of

Agnès Doiron MayorRoger R. Chiasson Councillor at LargeMarcelin Thériault Councillor at LargeCyrénus Doiron Councillor, Ward 1Sylvio Lanteigne Councillor, Ward 2Jean-Marie Gionet Councillor, Ward 3Daniel Gionet Councillor, Ward 4

Bath, Village of Troy F.J. Stone MayorBarbara Lynn McIntosh

Councillor at Large

Charles H. McNair Councillor at LargeJodi A. O’Neil Councillor at Large

Bathurst, City of Stephen J. Brunet MayorBob Anderson Councillor at LargeMichelle Branch Councillor at LargeHugh L. Comeau Councillor at LargeScott A. Ferguson Councillor at LargeAnne-Marie Gammon Councillor at LargeSerge Lagacé Councillor at LargeDanny (Daniel) Roy Councillor at LargeSusie Roy Councillor at Large

Beaubassin EastRural Community

Maryse LeBlanc (Boudreau)

Mayor

Ronnie Pierre Duguay Councillor, Ward 1Omer Leger Councillor, Ward 1Gilles Cormier Councillor, Ward 2André Bourque Councillor, Ward 3Kevin Caissie Councillor, Ward 3Jean Paul Melanson Councillor, Ward 3Richard P. Ratelle Councillor, Ward 4Gaétan LeBlanc Councillor, Ward 5Laurie Joseph McGraw

Councillor, Ward 6

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET DE COMMUNAUTÉS RURALES

Municipalité ou communauté rurale(nom incorporé)

Nom du candidatou de la candidate Poste

Alma, Village d’ Herta Kirstin Shortt MaireRyan H. Butland Conseiller généralAndrew James Casey Conseiller généralFred V. Hall Conseiller général

Aroostook, Village d’ Marven C. Demmings MaireTina L. Lockhart Conseillère généraleEileen P. McLaughlin Conseillère généraleLynn Nunn Conseillère générale

Atholville, Village d’ Michel Soucy MaireBetty Cleveland Firth Conseillère généraleGaëtan Cormier Conseiller généralGerard Fallu Conseiller généralMaurice Power Conseiller généralJean Soucy Conseiller général

Baker-Brook (village) Francine Caron MaireEmilien Bonenfant Conseiller généralJoan Levesque Conseillère généraleSuzanne Morneault Conseillère généraleJeannette Raymond Conseillère générale

Balmoral, Village of (village)

Charles Bernard MaireClaude F. Arseneault Conseiller généralJean Paul Bélanger Conseiller généralGuy J. Landry Conseiller généralJosée (Dou Dou) Levesque

Conseillère générale

Donald Savoie Conseiller général

Bas-Caraquet, Village de

Agnès Doiron MaireRoger R. Chiasson Conseiller généralMarcelin Thériault Conseiller généralCyrénus Doiron Conseiller, Quartier 1Sylvio Lanteigne Conseiller, Quartier 2Jean-Marie Gionet Conseiller, Quartier 3Daniel Gionet Conseiller, Quartier 4

Bath, Village of (village)

Troy F.J. Stone MaireBarbara Lynn McIntosh

Conseillère générale

Charles H. McNair Conseiller généralJodi A. O’Neil Conseiller général

Bathurst, City of (cité) Stephen J. Brunet MaireBob Anderson Conseiller généralMichelle Branch Conseillère généraleHugh L. Comeau Conseiller généralScott A. Ferguson Conseiller généralAnne-Marie Gammon Conseillère généraleSerge Lagacé Conseiller généralDanny (Daniel) Roy Conseiller généralSusie Roy Conseillère générale

Beaubassin-est, Communauté rurale de

Maryse LeBlanc(Boudreau)

Maire

Ronnie Pierre Duguay Conseiller, Quartier 1Omer Leger Conseiller, Quartier 1Gilles Cormier Conseiller, Quartier 2André Bourque Conseiller, Quartier 3Kevin Caissie Conseiller, Quartier 3Jean Paul Melanson Conseiller, Quartier 3Richard P. Ratelle Conseiller, Quartier 4Gaétan LeBlanc Conseiller, Quartier 5Laurie Joseph McGraw

Conseiller, Quartier 6

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1121 Gazette royale — 11 juillet 2012

Belledune (village) Ron Bourque MayorJerry Guitard Councillor at LargeGary J. Mazerolle Councillor at LargeHeather Frenette Councillor, Ward 1Mario A. Lapointe Councillor, Ward 2Tracy D. Culligan Councillor, Ward 3

Beresford (town) Paul Losier MayorRobert A. DeGrâce Councillor at LargeUlric DeGrâce Councillor at LargeBruno Poirier Councillor at LargeGilles Halley Councillor, Ward AJean Guy Grant Councillor, Ward B

Bertrand (village) Yvon Godin MayorClaude Clément Councillor at LargeNathalie Haché-Godin

Councillor at Large

Rodrigue Léger Councillor at LargeDaniel Pinet Councillor at LargeHuguette Thériault Councillor at Large

Blacks Harbour (village)

Terry James MayorDarlene F. Anthony Councillor at LargeCarolyn M. Breau Councillor at LargeMike T. Chase Councillor at LargeNatalie Caroline Harris

Councillor at Large

David R. Mahar Councillor at Large

Blackville, Village of Harold (Hal) Peter Muck

Mayor

Christopher David Hennessy

Councillor at Large

Cindy M. Ross Councillor at LargeMatthew William Sturgeon

Councillor at Large

Bouctouche (town) Aldéo Saulnier MayorRoland A. Fougère Councillor at LargePauline Hébert Councillor at LargeMichael (Mike) LeBlanc

Councillor at Large

Oscar LeBlanc Councillor at Large

Cambridge-Narrows, Village of

Blair C. Cummings MayorJudith B. Jones Councillor at LargeNancy LynnMcConnachie

Councillor at Large

Tom Nisbet Councillor at Large

Campbellton, City of Bruce N. MacIntosh MayorIan Comeau Councillor at LargeDiane M. Cyr Councillor at LargeGilbert E. Cyr Councillor at LargeSterling (Fuzzy) Loga Councillor at LargeChristian Mercier Councillor at LargeDenis Turcotte Councillor at Large

Campobello Island, Rural Community of

Stephen David Smart MayorRaymond C. Brown Councillor at LargeKevin Edward Sawtelle

Councillor, Ward 1

Terrance D. Preston Councillor, Ward 2Corliss M. Calder Councillor, Ward 3

Canterbury, Village of

Elaine B. English MayorAmanda Durling Councillor at LargeGlendon J. Luimes Councillor at LargeSandra J. Marston Councillor at LargeShawn Oldenburg Councillor at Large

Belledune (village) Ron Bourque MaireJerry Guitard Conseiller généralGary J. Mazerolle Conseiller généralHeather Frenette Conseillère, Quartier 1Mario A. Lapointe Conseiller, Quartier 2Tracy D. Culligan Conseillère, Quartier 3

Beresford (ville) Paul Losier MaireRobert A. DeGrâce Conseiller généralUlric DeGrâce Conseiller généralBruno Poirier Conseiller généralGilles Halley Conseiller, Quartier AJean Guy Grant Conseiller, Quartier B

Bertrand (village) Yvon Godin MaireClaude Clément Conseiller généralNathalie Haché-Godin

Conseillère générale

Rodrigue Léger Conseiller généralDaniel Pinet Conseiller généralHuguette Thériault Conseillère générale

Blacks Harbour (village)

Terry James MaireDarlene F. Anthony Conseillère généraleCarolyn M. Breau Conseillère généraleMike T. Chase Conseiller généralNatalie Caroline Harris

Conseillère générale

David R. Mahar Conseiller général

Blackville, Village of (village)

Harold (Hal) Peter Muck

Maire

Christopher David Hennessy

Conseiller général

Cindy M. Ross Conseillère généraleMatthew William Sturgeon

Conseiller général

Bouctouche (ville) Aldéo Saulnier MaireRoland A. Fougère Conseiller généralPauline Hébert Conseillère généraleMichael (Mike) LeBlanc

Conseiller général

Oscar LeBlanc Conseiller général

Cambridge-Narrows, Village de

Blair C. Cummings MaireJudith B. Jones Conseillère généraleNancy LynnMcConnachie

Conseillère générale

Tom Nisbet Conseiller général

Campbellton, City of (cité)

Bruce N. MacIntosh MaireIan Comeau Conseiller généralDiane M. Cyr Conseillère généraleGilbert E. Cyr Conseiller généralSterling (Fuzzy) Loga Conseiller généralChristian Mercier Conseiller généralDenis Turcotte Conseiller général

Campobello Island, Communauté rurale de

Stephen David Smart MaireRaymond C. Brown Conseiller généralKevin Edward Sawtelle

Conseiller, Quartier 1

Terrance D. Preston Conseiller, Quartier 2Corliss M. Calder Conseiller, Quartier 3

Canterbury, Village de

Elaine B. English MaireAmanda Durling Conseillère généraleGlendon J. Luimes Conseiller généralSandra J. Marston Conseillère généraleShawn Oldenburg Conseiller général

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1122 Gazette royale — 11 juillet 2012

Cap-Pelé (village) Debbie Dodier MayorHector Cormier Councillor at LargeHector R. Doiron Councillor at LargeAndré LeBlanc Councillor at LargeEliza A. LeBlanc Councillor at LargeSerge Leger Councillor at Large

Caraquet (town) Kevin J. Haché MayorJean-Guy Blanchard Councillor, Ward 1Rosaire Labrie Councillor, Ward 1Michel G. Boucher Councillor, Ward 2Yves Roy Councillor, Ward 2Louise Blanchard Councillor, Ward 3Marie-Soleil Landry Councillor, Ward 3Mariette Paulin Councillor, Ward 4Mario Vienneau Councillor, Ward 4

Centreville (village) Gary R. Thomas MayorKathryn J. Davenport Councillor at LargeRobert Gerald Lee Councillor at LargeMichael John Stewart Councillor at Large

Charlo, Village of Jason Carter MayorAlbert Gauvin Councillor at LargeRoger Joseph Leclair Councillor at LargeDenis McIntyre Councillor at LargeJoanne M. Mercier Councillor at LargeFloyd Vincent Councillor at Large

Chipman, Village of Edward Farris MayorCarol Sharon Boyd Councillor at LargeFaith Ellen Kennedy Councillor at LargeRobin Wasson Councillor at LargeKeith Victor West Councillor at Large

Clair, Village of Pierre Michaud MayorMichael E. Bossé Councillor at LargeJosée Lang Councillor at LargeMarc R. Long Councillor at LargeJosée Richard Councillor at Large

Dalhousie, Town of Clem Tremblay MayorRoland Dumont Councillor at LargeGail Fearon Councillor at LargeDaniel Edward Harquail

Councillor at Large

Jacqueline Leclair Councillor at LargeAnthony (Andy) Letourneau

Councillor at Large

Peter Thorne Councillor at Large

Dieppe (city) Yvon Lapierre MayorJody Dallaire Councillor at LargeJean J. Gaudet Councillor at LargeJordan E. Nowlan Councillor at LargeJean-Marc Brideau Councillor, Ward 1Jean-Claude Cormier Councillor, Ward 2Paul N. Belliveau Councillor, Ward 3Ernest Thibodeau Councillor, Ward 4Roger J. LeBlanc Councillor, Ward 5

Doaktown, Village of Beverly K. Gaston MayorWayne N. Fowler Councillor at LargePaul M. Gillespie Councillor at LargeJeff D. Porter Councillor at LargeTanya Jane Robichaud

Councillor at Large

Dorchester, Village of Jerome Simon Bear MayorRobert Corkerton Councillor at LargeGrant E. MacDonald Councillor at LargeSusan D. MacDonald Councillor at LargeKim M. MacLeod Councillor at Large

Cap-Pelé (village) Debbie Dodier MaireHector Cormier Conseiller généralHector R. Doiron Conseiller généralAndré LeBlanc Conseiller généralEliza A. LeBlanc Conseillère généraleSerge Leger Conseiller général

Caraquet (ville) Kevin J. Haché MaireJean-Guy Blanchard Conseiller, Quartier 1Rosaire Labrie Conseiller, Quartier 1Michel G. Boucher Conseiller, Quartier 2Yves Roy Conseiller, Quartier 2Louise Blanchard Conseillère, Quartier 3Marie-Soleil Landry Conseillère, Quartier 3Mariette Paulin Conseillère, Quartier 4Mario Vienneau Conseiller, Quartier 4

Centreville (village) Gary R. Thomas MaireKathryn J. Davenport Conseillère généraleRobert Gerald Lee Conseiller généralMichael John Stewart Conseiller général

Charlo, Village de Jason Carter MaireAlbert Gauvin Conseiller généralRoger Joseph Leclair Conseiller généralDenis McIntyre Conseiller généralJoanne M. Mercier Conseillère généraleFloyd Vincent Conseiller général

Chipman, Village of (village)

Edward Farris MaireCarol Sharon Boyd Conseillère généraleFaith Ellen Kennedy Conseillère généraleRobin Wasson Conseiller généralKeith Victor West Conseiller général

Clair, Village of (village)

Pierre Michaud MaireMichael E. Bossé Conseiller généralJosée Lang Conseillère généraleMarc R. Long Conseiller généralJosée Richard Conseillère générale

Dalhousie, Town of (ville)

Clem Tremblay MaireRoland Dumont Conseiller généralGail Fearon Conseillère généraleDaniel Edward Harquail

Conseiller général

Jacqueline Leclair Conseillère généraleAnthony (Andy) Letourneau

Conseiller général

Peter Thorne Conseiller général

Dieppe (cité) Yvon Lapierre MaireJody Dallaire Conseillère généraleJean J. Gaudet Conseiller généralJordan E. Nowlan Conseiller généralJean-Marc Brideau Conseiller, Quartier 1Jean-Claude Cormier Conseiller, Quartier 2Paul N. Belliveau Conseiller, Quartier 3Ernest Thibodeau Conseiller, Quartier 4Roger J. LeBlanc Conseiller, Quartier 5

Doaktown, Village de Beverly K. Gaston MaireWayne N. Fowler Conseiller généralPaul M. Gillespie Conseiller généralJeff D. Porter Conseiller généralTanya Jane Robichaud

Conseillère générale

Dorchester, Village de Jerome Simon Bear MaireRobert Corkerton Conseiller généralGrant E. MacDonald Conseiller généralSusan D. MacDonald Conseillère généraleKim M. MacLeod Conseillère générale

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1123 Gazette royale — 11 juillet 2012

Drummond (village) Cyril Rioux MayorGilles Beaulieu Councillor at LargeDonald Martin Councillor at LargeFrance Roussel Councillor at LargeMichel St-Amand Councillor at Large

Edmundston (city) Cyrille Simard MayorAndré Lang Councillor, Ward 1Guy A. Voyer Councillor, Ward 1Denis M. Pelletier Councillor, Ward 2Camille Roy Councillor, Ward 2Martin (Tin) Albert Councillor, Ward 3Gérald G. Morneault Councillor, Ward 3Charles E. Fournier Councillor, Ward 4Jean-Guy Marquis Councillor, Ward 4

Eel River Crossing, Village of

Denis Savoie MayorLaurent Hachey Councillor at LargeFrançois Levesque Councillor at LargeRhéal Joseph Pelletier Councillor at LargeManon Savoie Councillor at Large

Florenceville-Bristol(town)

Karl E. Curtis MayorElizabeth D. Campbell

Councillor, Ward 1

Daniel W. Guest Councillor, Ward 1Janice M. Kinney Councillor, Ward 1Thomas J. Davidson Councillor, Ward 2Nancy Whyte McCauley

Councillor, Ward 2

Rick Pryde Councillor, Ward 2

Fredericton, The City of

Brad Woodside MayorDan R. Keenan Councillor, Ward 1Bruce Grandy Councillor, Ward 2Mike O’Brien Councillor, Ward 3Eric W. Megarity Councillor, Ward 4Steven Hicks Councillor, Ward 5Marylin K. Kerton Councillor, Ward 6Scott McConaghy Councillor, Ward 7Greg Ericson Councillor, Ward 8Stephen A. Chase Councillor, Ward 9Leah Levac Councillor, Ward 10Kate Rogers Councillor, Ward 11David A.J. Kelly Councillor, Ward 12

Fredericton Junction, Village of

Gary W. Mersereau MayorJohn B. Bigger Councillor at LargeLonnie W. Daley Councillor at LargeMark K. Mersereau Councillor at LargeJames Webb Councillor at Large

Gagetown, Village of Michael Blaney MayorFrank John G. Massoeurs

Councillor at Large

Janice A. Perry Councillor at LargeDerek Pleadwell Councillor at LargeAntony T. Ratliffe Councillor at Large

Grand Bay-Westfield (town)

Grace Losier MayorDavid R. Calvin Councillor at LargeBeverley A. Day Councillor at LargeSteve D. Evans Councillor at LargeMichael Bruce Likely Councillor at LargeH. Ryan Snodgrass Councillor at Large

Grand Falls (town) Richard Keeley MayorJacques Lafrance Councillor, North

WardMichel (Rocky) Ouellette

Councillor, North Ward

Renaud Ouellette Councillor, North Ward

Drummond (village) Cyril Rioux MaireGilles Beaulieu Conseiller généralDonald Martin Conseiller généralFrance Roussel Conseiller généralMichel St-Amand Conseiller général

Edmundston (cité) Cyrille Simard MaireAndré Lang Conseiller, Quartier 1Guy A. Voyer Conseiller, Quartier 1Denis M. Pelletier Conseiller, Quartier 2Camille Roy Conseiller, Quartier 2Martin (Tin) Albert Conseiller, Quartier 3Gérald G. Morneault Conseiller, Quartier 3Charles E. Fournier Conseiller, Quartier 4Jean-Guy Marquis Conseiller, Quartier 4

Eel River Crossing, Village de

Denis Savoie MaireLaurent Hachey Conseiller généralFrançois Levesque Conseiller généralRhéal Joseph Pelletier Conseiller généralManon Savoie Conseillère générale

Florenceville-Bristol (ville)

Karl E. Curtis MaireElizabeth D. Campbell

Conseillère, Quartier 1

Daniel W. Guest Conseiller, Quartier 1Janice M. Kinney Conseillère, Quartier 1Thomas J. Davidson Conseiller, Quartier 2Nancy Whyte McCauley

Conseillère, Quartier 2

Rick Pryde Conseiller, Quartier 2

Fredericton, The City of (cité)

Brad Woodside MaireDan R. Keenan Conseiller, Quartier 1Bruce Grandy Conseiller, Quartier 2Mike O’Brien Conseiller, Quartier 3Eric W. Megarity Conseiller, Quartier 4Steven Hicks Conseiller, Quartier 5Marylin K. Kerton Conseillère, Quartier 6Scott McConaghy Conseiller, Quartier 7Greg Ericson Conseiller, Quartier 8Stephen A. Chase Conseiller, Quartier 9Leah Levac Conseillère, Quartier 10Kate Rogers Conseillère, Quartier 11David A.J. Kelly Conseiller, Quartier 12

Fredericton Junction, Village de

Gary W. Mersereau MaireJohn B. Bigger Conseiller généralLonnie W. Daley Conseiller généralMark K. Mersereau Conseiller généralJames Webb Conseiller général

Gagetown, Village de Michael Blaney MaireFrank John G. Massoeurs

Conseiller général

Janice A. Perry Conseillère généraleDerek Pleadwell Conseiller généralAntony T. Ratliffe Conseiller général

Grand Bay-Westfield (ville)

Grace Losier MaireDavid R. Calvin Conseiller généralBeverley A. Day Conseillère généraleSteve D. Evans Conseiller généralMichael Bruce Likely Conseiller généralH. Ryan Snodgrass Conseiller général

Grand-Sault (ville) Richard Keeley MaireJacques Lafrance Conseiller, Quartier

NordMichel (Rocky) Ouellette

Conseiller, Quartier Nord

Renaud Ouellette Conseiller, Quartier Nord

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1124 Gazette royale — 11 juillet 2012

Arthelin Y. Rossignol Councillor, North Ward

John Bellefleur Councillor, South WardRino Long Councillor, South WardHarry A. MacPhail Councillor, South WardJean-Paul (JP) Proulx Councillor, South Ward

Grand Manan (village)

Dennis C. Greene MayorJane J. E. Cary Councillor at LargeKirk L. Cheney Councillor at LargePhillip D. Ells (Jr) Councillor at LargeMaurice W. Green Councillor at LargeMark A. Ingersoll Councillor at LargeBonnie H. Morse Councillor at LargeRobert C. Moses Councillor at LargeDennis (Pete) J. Sesplankis

Councillor at Large

Jayne B. Turner Councillor at Large

Grande-Anse (village)

Yves Létourneau MayorAnne Landry Councillor at LargeLouise Legresley Councillor at LargePhilippe Poirier Councillor at LargeGaëtan J. Thériault Councillor at Large

Hampton (town) Ken Chorley MayorPeter T. Behr Councillor at LargeDwight A. Bond Councillor at LargeGary Crossman Councillor at LargeRobert D. Doucet Councillor at Large

Hartland, Town of J. Craig Melanson MayorWayne D. Britton Councillor at LargeTracey D. Demerchant

Councillor at Large

Travis Dickinson Councillor at LargePatrick Harris Councillor at Large

Harvey, Village of Winston Gamblin MayorRichard H. Corey Councillor at LargeRonald A. Goodine Councillor at LargeFloyd O. Thompson Councillor at Large

Hillsborough, Village of

Patrick E. Armstrong MayorGeorge R. Forsythe Councillor at LargeJeff A. Jonah Councillor at LargeBarry E. Snider Councillor at LargeGrant Woodworth Councillor at Large

Kedgwick (rural community)

Jean Paul (JP) Savoie MayorCarmen St-Pierre Councillor at LargeMarc Talbot Councillor at LargeJosée Nancy Pitre Councillor, Ward 1Maurice Dion Councillor, Ward 2Éric Gagnon Councillor, Ward 3Michel Leonard Councillor, Ward 4

Lac Baker, Village of Alpha Nadeau MayorConrad Banville Councillor at LargeRaymond Gagné Councillor at LargeMax Michaud Councillor at LargeDanny Nadeau Councillor at Large

Lamèque (town) Réginald Paulin MayorGérard Benoit Councillor at LargeGuy O. Chiasson Councillor at LargeMarie-Anne Ferron Councillor at LargeJules Haché Councillor at LargeLinda Robichaud Blanchard

Councillor at Large

Simon Savoie Councillor at Large

Arthelin Y. Rossignol Conseiller, Quartier Nord

John Bellefleur Conseiller, Quartier SudRino Long Conseiller, Quartier SudHarry A. MacPhail Conseiller, Quartier SudJean-Paul (JP) Proulx Conseiller, Quartier Sud

Grand Manan (village)

Dennis C. Greene MaireJane J. E. Cary Conseillère généraleKirk L. Cheney Conseiller généralPhillip D. Ells (Jr) Conseiller généralMaurice W. Green Conseiller généralMark A. Ingersoll Conseiller généralBonnie H. Morse Conseillère généraleRobert C. Moses Conseiller généralDennis (Pete) J. Sesplankis

Conseiller général

Jayne B. Turner Conseillère générale

Grande-Anse (village)

Yves Létourneau MaireAnne Landry Conseillère généraleLouise Legresley Conseillère généralePhilippe Poirier Conseiller généralGaëtan J. Thériault Conseiller général

Hampton (ville) Ken Chorley MairePeter T. Behr Conseiller généralDwight A. Bond Conseiller généralGary Crossman Conseiller généralRobert D. Doucet Conseiller général

Hartland, Town of J. Craig Melanson MaireWayne D. Britton Conseiller généralTracey D. Demerchant

Conseillère générale

Travis Dickinson Conseiller généralPatrick Harris Conseiller général

Harvey, Village de Winston Gamblin MaireRichard H. Corey Conseiller généralRonald A. Goodine Conseiller généralFloyd O. Thompson Conseiller général

Hillsborough, Village of (village)

Patrick E. Armstrong MaireGeorge R. Forsythe Conseiller généralJeff A. Jonah Conseiller généralBarry E. Snider Conseiller généralGrant Woodworth Conseiller général

Kedgwick (communauté rurale)

Jean Paul (JP) Savoie MaireCarmen St-Pierre Conseillère généraleMarc Talbot Conseiller généralJosée Nancy Pitre Conseillère, Quartier 1Maurice Dion Conseiller, Quartier 2Éric Gagnon Conseiller, Quartier 3Michel Leonard Conseiller, Quartier 4

Lac Baker, Village of (village)

Alpha Nadeau MaireConrad Banville Conseiller généralRaymond Gagné Conseiller généralMax Michaud Conseiller généralDanny Nadeau Conseiller général

Lamèque (ville) Réginald Paulin MaireGérard Benoit Conseiller généralGuy O. Chiasson Conseiller généralMarie-Anne Ferron Conseillère généraleJules Haché Conseiller généralLinda Robichaud Blanchard

Conseillère générale

Simon Savoie Conseiller général

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1125 Gazette royale — 11 juillet 2012

Le Goulet (village) Wilfred Roussel MayorSerge Lemay Councillor at LargePaul-Aimé Mallet Councillor at LargeMadeleine Roussel Councillor at LargeLorina Vienneau Councillor at Large

Maisonnette (village) Jason Godin MayorJules Boudreau Councillor at LargeJoanne Cormier Baldwin

Councillor at Large

Mathieu F. Perron Councillor at LargeRené Poirier Councillor at Large

McAdam, Village of Frank M. Carroll MayorDouglas J. Goss Councillor at LargeJohn C. Kilbride Councillor at LargeStephen B. Sloan Councillor at LargeGreg C. Swim Councillor at Large

Meductic (village) Lance Royden Graham

Mayor

Donna M. Davidson Councillor at LargeJamie R. Lauzier Councillor at LargeRandall Allan Stairs Councillor at Large

Memramcook (village)

Donald O. LeBlanc MayorJoe Breau Councillor at LargeVictor LeBlanc Councillor, Ward 1Raoul Boudreau Councillor, Ward 2Brian Cormier Councillor, Ward 3Donald (Barber) LeBlanc

Councillor, Ward 4

Robert Cormier Councillor, Ward 5

Millville (village) Beverly H. Forbes MayorDean Wallace Bell Councillor at LargeTrevor J. Gullison Councillor at LargeJulie Marie McConaghy

Councillor at Large

Minto, Village of Eric G. Barnett MayorKris Austin Councillor at LargeDwain Leslie Barton Councillor at LargeHank A. E. Daamen Councillor at LargeWendy Leigh Robichaud

Councillor at Large

Miramichi (city) Gerry Cormier MayorJoan M. Cripps Councillor at LargeBilly Fleiger Councillor at LargeJohn Winston Foran Councillor at LargeLisa L. Harris Councillor at LargeBrian J. King Councillor at LargeNancy Lordon Councillor at LargePeggy M. McLean Councillor at LargeShelly A. Williams Councillor at Large

Moncton (city) George H. LeBlanc MayorDawn Arnold Councillor at LargePierre A. Boudreau Councillor at LargeShawn Crossman Councillor, Ward 1Paulette Thériault Councillor, Ward 1Merrill Henderson Councillor, Ward 2Charles Leger Councillor, Ward 2Daniel Bourgeois Councillor, Ward 3Brian A. Hicks Councillor, Ward 3Rene (Pepsi) Landry Councillor, Ward 4Paul A. Pellerin Councillor, Ward 4

Nackawic (town) Nancy A. Cronkhite MayorJanet L. Caldwell Councillor at LargeGail M. Farnsworth Councillor at LargeJennifer Lynn Lamey Councillor at Large

Le Goulet (village) Wilfred Roussel MaireSerge Lemay Conseiller généralPaul-Aimé Mallet Conseiller généralMadeleine Roussel Conseillère généraleLorina Vienneau Conseillère générale

Maisonnette (village) Jason Godin MaireJules Boudreau Conseiller généralJoanne Cormier Baldwin

Conseillère générale

Mathieu F. Perron Conseiller généralRené Poirier Conseiller général

McAdam, Village de Frank M. Carroll MaireDouglas J. Goss Conseiller généralJohn C. Kilbride Conseiller généralStephen B. Sloan Conseiller généralGreg C. Swim Conseiller général

Meductic (village) Lance Royden Graham

Maire

Donna M. Davidson Conseillère généraleJamie R. Lauzier Conseiller généralRandall Allan Stairs Conseiller général

Memramcook (village)

Donald O. LeBlanc MaireJoe Breau Conseiller généralVictor LeBlanc Conseiller, Quartier 1Raoul Boudreau Conseiller, Quartier 2Brian Cormier Conseiller, Quartier 3Donald (Barber) LeBlanc

Conseiller, Quartier 4

Robert Cormier Conseiller, Quartier 5

Millville (village) Beverly H. Forbes MaireDean Wallace Bell Conseiller généralTrevor J. Gullison Conseiller généralJulie Marie McConaghy

Conseillère générale

Minto, Village of (village)

Eric G. Barnett MaireKris Austin Conseiller généralDwain Leslie Barton Conseiller généralHank A. E. Daamen Conseiller généralWendy Leigh Robichaud

Conseillère générale

Miramichi (cité) Gerry Cormier MaireJoan M. Cripps Conseillère généraleBilly Fleiger Conseiller généralJohn Winston Foran Conseiller généralLisa L. Harris Conseillère généraleBrian J. King Conseiller généralNancy Lordon Conseillère généralePeggy M. McLean Conseillère généraleShelly A. Williams Conseillère générale

Moncton (cité) George H. LeBlanc MaireDawn Arnold Conseillère généralePierre A. Boudreau Conseiller généralShawn Crossman Conseiller, Quartier 1Paulette Thériault Conseillère, Quartier 1Merrill Henderson Conseiller, Quartier 2Charles Leger Conseiller, Quartier 2Daniel Bourgeois Conseiller, Quartier 3Brian A. Hicks Conseiller, Quartier 3Rene (Pepsi) Landry Conseiller, Quartier 4Paul A. Pellerin Conseiller, Quartier 4

Nackawic (ville) Nancy A. Cronkhite MaireJanet L. Caldwell Conseillère généraleGail M. Farnsworth Conseillère généraleJennifer Lynn Lamey Conseillère générale

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1126 Gazette royale — 11 juillet 2012

Doug J. Mercer Councillor at LargeBrian E. Toole Councillor at Large

Neguac (village) Georges Rhéal Savoie MayorLucie Breau Councillor at LargeMarcel A. Cyr Councillor at LargeAlbertine Y. Savoie Councillor at LargeEymard Savoie Councillor at LargeGisèle Savoie Breau Councillor at Large

New Maryland (village)

Judy E. Wilson-Shee MayorFrank C. Dunn Councillor at LargePaul E. LeBlanc Councillor at LargeGisèle McCaie-Burke Councillor at LargeScott Sparks Councillor at LargePeter E. Wiggins Councillor at Large

Nigadoo (village) Gilberte Boudreau MayorJean-Paul Arseneau Councillor at LargeReno Arseneau Councillor at LargeCharles Henri Doucet Councillor at LargeRobert J. Gaudet Councillor at Large

Norton, Village of Juliana Catherine Booth

Mayor

Nicole Marie Clement Councillor at LargeLawrence E. Dykeman

Councillor at Large

Harold O. Keith Councillor at LargeAnne-Marie Snyder Councillor at Large

Oromocto (town) Robert (Bob) Edward Powell

Mayor

Lorraine Dawe Councillor, Ward 1Jeff Kirkbride Councillor, Ward 1Chris L. Corbett Councillor, Ward 2Daryll Mooney Councillor, Ward 2Sheridan W. Mawhinney

Councillor, Ward 3

Bruce Parks Councillor, Ward 3

Paquetville, Village of

André Gozzo MayorDianne Butler Councillor at LargeBertrand Godin Councillor at LargeCarmen Thériault Councillor at LargeLine Thériault Councillor at Large

Perth-Andover, Village of

Terrence Peter Ritchie MayorRickey Allen Beaulieu

Councillor at Large

Tommy J. Dixon Councillor at LargeShawn Durepos Councillor at LargeMichael E. Grant Councillor at LargeDean E. McAllister Councillor at Large

Petit-Rocher (village) Luc Desjardins MayorRéjean Guitard Councillor at LargeStephane LeBlanc Councillor at LargeAlma-Jeanne Morrison

Councillor at Large

Donald Roy Councillor at Large

Petitcodiac, Village of Gerald A. W. Gogan MayorCathy Lynn McCully Councillor at LargeAshley (Dennis) Murphy

Councillor at Large

Dan Pollock Councillor at LargeMalcolm W. Robinson

Councillor at Large

Peter Saunders Councillor at Large

Doug J. Mercer Conseiller généralBrian E. Toole Conseiller général

Neguac (village) Georges Rhéal Savoie MaireLucie Breau Conseillère généraleMarcel A. Cyr Conseiller généralAlbertine Y. Savoie Conseillère généraleEymard Savoie Conseiller généralGisèle Savoie Breau Conseillère générale

New Maryland (village)

Judy E. Wilson-Shee MaireFrank C. Dunn Conseiller généralPaul E. LeBlanc Conseiller généralGisèle McCaie-Burke Conseillère généraleScott Sparks Conseiller généralPeter E. Wiggins Conseiller général

Nigadoo (village) Gilberte Boudreau MaireJean-Paul Arseneau Conseiller généralReno Arseneau Conseiller généralCharles Henri Doucet Conseiller généralRobert J. Gaudet Conseiller général

Norton, Village of (village)

Juliana Catherine Booth

Maire

Nicole Marie Clement Conseillère généraleLawrence E. Dykeman

Conseiller général

Harold O. Keith Conseiller généralAnne-Marie Snyder Conseillère générale

Oromocto (ville) Robert (Bob) Edward Powell

Maire

Lorraine Dawe Conseillère, Quartier 1Jeff Kirkbride Conseiller, Quartier 1Chris L. Corbett Conseiller, Quartier 2Daryll Mooney Conseiller, Quartier 2Sheridan W. Mawhinney

Conseiller, Quartier 3

Bruce Parks Conseiller, Quartier 3

Paquetville, Village de

André Gozzo MaireDianne Butler Conseillère généraleBertrand Godin Conseiller généralCarmen Thériault Conseillère généraleLine Thériault Conseillère générale

Perth-Andover, Village de

Terrence Peter Ritchie MaireRickey Allen Beaulieu

Conseiller général

Tommy J. Dixon Conseiller généralShawn Durepos Conseiller généralMichael E. Grant Conseiller généralDean E. McAllister Conseiller général

Petit-Rocher (village) Luc Desjardins MaireRéjean Guitard Conseiller généralStephane LeBlanc Conseiller généralAlma-Jeanne Morrison

Conseillère générale

Donald Roy Conseiller général

Petitcodiac, Village de Gerald A. W. Gogan MaireCathy Lynn McCully Conseillère généraleAshley (Dennis) Murphy

Conseiller général

Dan Pollock Conseiller généralMalcolm W. Robinson

Conseiller général

Peter Saunders Conseiller général

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1127 Gazette royale — 11 juillet 2012

Plaster Rock (village) Alexis D. Fenner MayorTimothy M. Corbin Councillor at LargeCarolyn J. Crawford Councillor at LargeTerry Leslie Harding Councillor at LargeTony C. Wright Councillor at Large

Pointe-Verte, Villagede (village)

Daniel Guitard MayorMarc Arseneau Councillor at LargeNormand Doiron Councillor at LargeAlvine Haché Councillor at LargeMichel Haché Councillor at LargeJohn Kowtaluk Councillor at Large

Port Elgin, Village of Judy E. Scott MayorTerrance L. Legere Councillor at LargeValerie A. MacDermid

Councillor at Large

Patricia (Patsy) Murphy

Councillor at Large

Tanya A. Trenholm Councillor at Large

Quispamsis (town) Murray Driscoll MayorGary D. Clark Councillor at LargeLisa Loughery Councillor at LargeKirk R. Miller Councillor at LargeLibby O’Hara Councillor at LargeEmil T. Olsen Councillor at LargeJ. Pierre Rioux Councillor at LargeBeth Thompson Councillor at Large

Rexton, Village of David L. Hanson MayorAlbert J. Corcoran Councillor at LargeWilliam (Billy)Edward Flanagan

Councillor at Large

Lisa Warman Councillor at LargeElaine Warren Councillor at Large

Richibucto (town) Roger Doiron MayorMartin F. LeBlanc Councillor at LargeGérard (Coco) Richard

Councillor at Large

Stella Richard Councillor at LargeDwayne Thompson Councillor at Large

Riverside-Albert, Village of

C. Dale Elliott MayorShirley L. Barbour Councillor at LargeJohn Jay Lefrançois Councillor at LargeKevin Ronald Rossiter

Councillor at Large

Riverview, Town of

Ann Seamans MayorCecile Cassista Councillor at LargeAndrew J. LeBlanc Councillor at LargeTom Toner Councillor at LargeLana Hansen Councillor, Ward 1Ian A. MacDonald Councillor, Ward 2Russell Hayward Councillor, Ward 3Wayne Bennett Councillor, Ward 4

Rivière-Verte, Village of

Michel Leblond MayorGino Couturier Councillor at LargeAlain Ouellette Councillor at LargeRinette Parent Councillor at LargeDaniel St-Germain Councillor at Large

Rogersville (village) Pierrette F. Robichaud MayorNoella Babineau Councillor at LargeJocelyne M. Bourque Councillor at LargeYvon Bourque Councillor at LargeRoger L. Richard Councillor at Large

Plaster Rock (village) Alexis D. Fenner MaireTimothy M. Corbin Conseiller généralCarolyn J. Crawford Conseillère généraleTerry Leslie Harding Conseiller généralTony C. Wright Conseiller général

Pointe-Verte, Village de

Daniel Guitard MaireMarc Arseneau Conseiller généralNormand Doiron Conseiller généralAlvine Haché Conseillère généraleMichel Haché Conseiller généralJohn Kowtaluk Conseiller général

Port Elgin, Village de Judy E. Scott MaireTerrance L. Legere Conseiller généralValerie A. MacDermid

Conseillère générale

Patricia (Patsy) Murphy

Conseillère générale

Tanya A. Trenholm Conseillère générale

Quispamsis (ville) Murray Driscoll MaireGary D. Clark Conseiller généralLisa Loughery Conseillère généraleKirk R. Miller Conseiller généralLibby O’Hara Conseillère généraleEmil T. Olsen Conseiller généralJ. Pierre Rioux Conseiller généralBeth Thompson Conseillère générale

Rexton, Village of (village)

David L. Hanson MaireAlbert J. Corcoran Conseiller généralWilliam (Billy) Edward Flanagan

Conseiller général

Lisa Warman Conseillère généraleElaine Warren Conseillère générale

Richibucto (ville) Roger Doiron MaireMartin F. LeBlanc Conseiller généralGérard (Coco) Richard

Conseiller général

Stella Richard Conseillère généraleDwayne Thompson Conseiller général

Riverside-Albert, Village de

C. Dale Elliott MaireShirley L. Barbour Conseillère généraleJohn Jay Lefrançois Conseiller généralKevin Ronald Rossiter

Conseiller général

Riverview, Town of (ville)

Ann Seamans MaireCecile Cassista Conseillère généraleAndrew J. LeBlanc Conseiller généralTom Toner Conseiller généralLana Hansen Conseillère, Quartier 1Ian A. MacDonald Conseiller, Quartier 2Russell Hayward Conseiller, Quartier 3Wayne Bennett Conseiller, Quartier 4

Rivière-Verte, Village de

Michel Leblond MaireGino Couturier Conseiller généralAlain Ouellette Conseiller généralRinette Parent Conseillère généraleDaniel St-Germain Conseiller général

Rogersville (village) Pierrette F. Robichaud MaireNoella Babineau Conseillère généraleJocelyne M. Bourque Conseillère généraleYvon Bourque Conseiller généralRoger L. Richard Conseiller général

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1128 Gazette royale — 11 juillet 2012

Rothesay (town) W. J. (Bill) Bishop MayorMatt Alexander Councillor at LargePatricia Gallagher Jette

Councillor at Large

Nancy E. Grant Councillor at LargePeter J. Lewis Councillor at LargeBlair R. MacDonald Councillor at LargeBill McGuire Councillor at LargeMiriam J. Wells Councillor at Large

Sackville, Town of Robert D. Berry MayorRonald B. Aiken Councillor at LargeRon E. Corbett Councillor at LargeBill Evans Councillor at LargeRobert Shawn Mesheau

Councillor at Large

Joyce O’Neil Councillor at LargeBruce Irving Phinney Councillor at LargeMichael J. Tower Councillor at LargeMargaret Tusz-King Councillor at Large

Saint-André, RuralCommunity of

Allain Desjardins MayorMicheline V. Desjardins

Councillor at Large

Marcel Levesque Councillor, Ward 1Lyn Ghyslaine Madore

Councillor, Ward 2

Alyre Mazerolle Councillor, Ward 3Nelson J. Benier Councillor, Ward 4Suzanne Lajeunesse M.

Councillor, Ward 5

Saint Andrews, Town of

Stanley M. Choptiany MayorCatherine A. Akagi Councillor at LargeEdie C. Bishop Councillor at LargeAlan J. Golding Councillor at LargeMary L. Myers Councillor at LargeLee Sochasky Councillor at LargeMelanie Rae Wood Councillor at Large

Sainte-Anne-de-Madawaska, Village of

Guy BellefleurHomeril (Prill) Corbin

MayorCouncillor at Large

Jean-Louis Francoeur Councillor at LargeJean-Yves Girard Councillor at LargeSylvie Girard Councillor at LargeRichard (Bie) Parent Councillor at Large

Saint-Antoine, Village de (village)

Roseline M. Maillet MayorEugere Cormier Councillor at LargeRonald Cormier Councillor at LargeClaude Goguen Councillor at LargeKelli Taylor Councillor at LargeJacques Williams Councillor at Large

Saint-François de Madawaska, Village of

Gérard Cyr MayorLise Landry Councillor at LargeChantal Veilleux Levesque

Councillor at Large

Colette Levesque Councillor at LargeSylvain St-Onge Councillor at Large

St. George, Town of

Daniel Joseph Henry MayorFaith E. Avery Councillor at LargeSterling P. Harris Councillor at LargeDerek Hatt Councillor at LargeDavid E. Hooper Councillor at LargeBruce D. Jackson Councillor at LargeGail D. Mullin Councillor at Large

Rothesay (ville) W. J. (Bill) Bishop MaireMatt Alexander Conseiller généralPatricia Gallagher Jette

Conseillère générale

Nancy E. Grant Conseillère généralePeter J. Lewis Conseiller généralBlair R. MacDonald Conseiller généralBill McGuire Conseiller généralMiriam J. Wells Conseillère générale

Sackville, Town of (ville)

Robert D. Berry MaireRonald B. Aiken Conseiller généralRon E. Corbett Conseiller généralBill Evans Conseiller généralRobert Shawn Mesheau

Conseiller général

Joyce O’Neil Conseillère généraleBruce Irving Phinney Conseiller généralMichael J. Tower Conseiller généralMargaret Tusz-King Conseillère générale

Saint-André, Communauté rurale de

Allain Desjardins MaireMicheline V. Desjardins

Conseillère générale

Marcel Levesque Conseiller, Quartier 1Lyn Ghyslaine Madore

Conseillère, Quartier 2

Alyre Mazerolle Conseiller, Quartier 3Nelson J. Benier Conseiller, Quartier 4Suzanne Lajeunesse

Conseillère, Quartier 5

Saint Andrews, Town of (ville)

Stanley M. Choptiany MaireCatherine A. Akagi Conseillère généraleEdie C. Bishop Conseillère généraleAlan J. Golding Conseiller généralMary L. Myers Conseillère généraleLee Sochasky Conseillère généraleMelanie Rae Wood Conseillère générale

Sainte-Anne-de-Madawaska, Villageof (village)

Guy BellefleurHomeril (Prill) Corbin

MaireConseiller général

Jean-Louis Francoeur Conseiller généralJean-Yves Girard Conseiller généralSylvie Girard Conseillère généraleRichard (Bie) Parent Conseiller général

Saint-Antoine, Village de

Roseline M. Maillet MaireEugere Cormier Conseiller généralRonald Cormier Conseiller généralClaude Goguen Conseiller généralKelli Taylor Conseillère généraleJacques Williams Conseiller général

Saint François de Madawaska, Village de

Gérard Cyr MaireLise Landry Conseillère généraleChantal Veilleux Levesque

Conseillère générale

Colette Levesque Conseillère généraleSylvain St-Onge Conseiller général

St. George, Town of (ville)

Daniel Joseph Henry MaireFaith E. Avery Conseillère généraleSterling P. Harris Conseiller généralDerek Hatt Conseiller généralDavid E. Hooper Conseiller généralBruce D. Jackson Conseiller généralGail D. Mullin Conseillère générale

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1129 Gazette royale — 11 juillet 2012

St. Hilaire, Village de (village)

Roland Dube MayorMarcel Long Councillor at LargeMarc Michel Morin Councillor at LargeRino Morneault Councillor at Large

Saint-Isidore (village) Oscar Roussel MayorRaymond Arsenault Councillor at LargeSerge Arsenault Councillor at LargeRené Doiron Councillor at LargeSuzanne Thériault Councillor at Large

Saint John, The City of

Mel K. Norton MayorShirley McAlary Councillor at LargeShelley M. Rinehart Councillor at LargeBill Farren Councillor, Ward 1Greg J. Norton Councillor, Ward 1Susan Fullerton Councillor, Ward 2John MacKenzie Councillor, Ward 2Donna Reardon Councillor, Ward 3Donnie Snook Councillor, Ward 3David Merrithew Councillor, Ward 4Ray Strowbridge Councillor, Ward 4

Saint-Léolin (village) Mathieu Chayer MayorGuy Bertin Councillor at LargeLinda G. Collin Councillor at LargeGuy Cormier Councillor at LargeVincent Downing Councillor at LargeMélanie Hachey Councillor at Large

Saint-Léonard (town) Carmel St-Amand MayorGail Dubé Councillor at LargeKenneth J. Akerley Councillor at LargeLuc Martin Councillor at LargeGuy Michaud Councillor at LargeRoland Michaud Councillor at Large

Saint-Louis de Kent (village)

Danielle Andrée Dugas

Mayor

Raymond Gallant Councillor at LargeChristine Johnson Councillor at LargeOswald Mazerolle Councillor at LargeHoward Vautour Councillor at Large

Sainte-Marie-Saint-Raphaël (village)

Henri-Pierre Duguay MayorMarie-Josée Chiasson Councillor at LargeEdith S. Duguay Councillor at LargeLinda R. Haché Councillor at LargeCorinne Savoie Councillor at LargeLouis-Paul Savoie Councillor at Large

St. Martins, Village of Bette Ann M. Chatterton

Mayor

Jason W. Garnett Councillor at LargePreston S. MacDonald Councillor at LargeJames M. Moran Councillor at Large

Saint-Quentin (town) Rodrigue Levesque MayorMartine Côté Councillor at LargeBertrand Leclerc Councillor at LargeJocelyne Querry Bossé

Councillor at Large

Nicole Somers Councillor at LargeMarie-Josée Thériault Councillor at Large

St. Stephen, The Town of

John B. Quartermain MayorJohn B. Ames Councillor at LargeR. Michael Booth Councillor at LargeMargaret (Marg)Harding

Councillor at Large

Debbie (Gullison) MacDonald

Councillor at Large

St. Hilaire, Village de Roland Dube MaireMarcel Long Conseiller généralMarc Michel Morin Conseiller généralRino Morneault Conseiller général

Saint-Isidore (village) Oscar Roussel MaireRaymond Arsenault Conseiller généralSerge Arsenault Conseiller généralRené Doiron Conseiller généralSuzanne Thériault Conseillère générale

Saint John, The City of (cité)

Mel K. Norton MaireShirley McAlary Conseillère généraleShelley M. Rinehart Conseillère généraleBill Farren Conseiller, Quartier 1Greg J. Norton Conseiller, Quartier 1Susan Fullerton Conseillère, Quartier 2John MacKenzie Conseiller, Quartier 2Donna Reardon Conseillère, Quartier 3Donnie Snook Conseiller, Quartier 3David Merrithew Conseiller, Quartier 4Ray Strowbridge Conseiller, Quartier 4

Saint-Léolin (village) Mathieu Chayer MaireGuy Bertin Conseiller généralLinda G. Collin Conseillère généraleGuy Cormier Conseiller généralVincent Downing Conseiller généralMélanie Hachey Conseillère générale

Saint-Léonard (ville) Carmel St-Amand MaireGail Dubé Conseillère généraleKenneth J. Akerley Conseiller généralLuc Martin Conseiller généralGuy Michaud Conseiller généralRoland Michaud Conseiller général

Saint-Louis de Kent (village)

Danielle Andrée Dugas

Maire

Raymond Gallant Conseiller généralChristine Johnson Conseillère généraleOswald Mazerolle Conseiller généralHoward Vautour Conseiller général

Sainte-Marie-Saint-Raphaël (village)

Henri-Pierre Duguay MaireMarie-Josée Chiasson Conseillère généraleEdith S. Duguay Conseillère généraleLinda R. Haché Conseillère généraleCorinne Savoie Conseillère généraleLouis-Paul Savoie Conseiller général

St. Martins, Village of (village)

Bette Ann M. Chatterton

Maire

Jason W. Garnett Conseiller généralPreston S. MacDonald Conseiller généralJames M. Moran Conseiller général

Saint-Quentin (ville) Rodrigue Levesque MaireMartine Côté Conseillère généraleBertrand Leclerc Conseiller généralJocelyne Querry Bossé

Conseillère générale

Nicole Somers Conseillère généraleMarie-Josée Thériault Conseillère générale

St. Stephen The Town of (ville)

John B. Quartermain MaireJohn B. Ames Conseiller généralR. Michael Booth Conseiller généralMargaret (Marg) Harding

Conseillère générale

Debbie (Gullison) MacDonald

Conseillère générale

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1130 Gazette royale — 11 juillet 2012

Allan L. MacEachern Councillor at LargeJim M. Maxwell Councillor at Large

Salisbury (village) Terry A. Keating MayorBlake Bartlett Councillor at LargeBeverly A. Best Councillor at LargeRobert (Robbie) W. Kitchen

Councillor at Large

Robert C. (Bob) Lamb Councillor at LargeWilliam (Bill) Wilson Councillor at Large

Shediac (town) Jacques LeBlanc MayorSylvie C. Boudeau Councillor at LargePatricia Bourque-Chevarie

Councillor at Large

Carmel Brun Councillor at LargeRoger G. Caissie Councillor at LargeMarc Fougère Councillor at LargeGermaine Gallant Councillor at LargeLaura Gallant Councillor at LargeAnita Léger-MacDonald

Councillor at Large

Shippagan (town) Tilmon Mallet MayorKassim Doumbia Councillor at LargeRémi Hébert Councillor at LargeJean-Marc Mallet Councillor at LargePatrice-Éloi Mallet Councillor at LargeAnita Savoie Robichaud

Councillor at Large

Jérôme Roy Councillor at Large

Stanley, Village of Mark A. J. Foreman MayorHeather Lyn Holt-Logan

Councillor at Large

Barbara MacDonald Councillor at LargeJames Frederick Pinnock

Councillor at Large

Sussex, Town of Marc Thorne MayorDeborah G. Armitage Councillor at LargeJane Boyle Councillor at LargeRalph A. Carr Councillor at LargeBridget L. A. Ryan Councillor at LargeJamie Stout-Hutchings

Councillor at Large

Tim W. Wilson Councillor at LargeMark Wright Councillor at Large

Sussex Corner, Village of

Steven G. Gillies MayorHarley L. Hunt Councillor at LargeSharon E. Loder Councillor at LargeFaith A. MacMillan Councillor at LargePatricia A. Shay Councillor at LargeM. Benjamin (Ben) Whalen

Councillor at Large

Tide Head, Village of Randy Hunter MayorGary W. Hickey Councillor at LargeCatherine L. Johnson-McDavid

Councillor at Large

Patrick Lanteigne Councillor at LargeMark St. Onge Councillor at Large

Tracadie-Sheila (town)

Aldéoda Losier MayorRose-Marie Doiron Councillor at LargeMarc Jean Councillor at LargeJean-Yves McGraw Councillor at LargeDenise McLaughlin Councillor at LargeFernand Paulin Councillor at LargeVera Paulin Councillor at Large

Allan L. MacEachern Conseiller généralJim M. Maxwell Conseiller général

Salisbury (village) Terry A. Keating MaireBlake Bartlett Conseiller généralBeverly A. Best Conseillère généraleRobert (Robbie) W. Kitchen

Conseiller général

Robert C. (Bob) Lamb Conseiller généralWilliam (Bill) Wilson Conseiller général

Shediac (ville) Jacques LeBlanc MaireSylvie C. Boudeau Conseillère généralePatricia Bourque-Chevarie

Conseillère générale

Carmel Brun Conseillère généraleRoger G. Caissie Conseiller généralMarc Fougère Conseiller généralGermaine Gallant Conseillère généraleLaura Gallant Conseillère généraleAnita Léger-MacDonald

Conseillère générale

Shippagan (ville) Tilmon Mallet MaireKassim Doumbia Conseiller généralRémi Hébert Conseiller généralJean-Marc Mallet Conseiller généralPatrice-Éloi Mallet Conseiller généralAnita Savoie Robichaud

Conseillère générale

Jérôme Roy Conseiller général

Stanley, Village de Mark A. J. Foreman MaireHeather Lyn Holt-Logan

Conseillère générale

Barbara MacDonald Conseillère généraleJames Frederick Pinnock

Conseiller général

Sussex, Town of (ville)

Marc Thorne MaireDeborah G. Armitage Conseillère généraleJane Boyle Conseillère généraleRalph A. Carr Conseiller généralBridget L. A. Ryan Conseillère généraleJamie Stout-Hutchings

Conseiller général

Tim W. Wilson Conseiller généralMark Wright Conseiller général

Sussex Corner, Village de

Steven G. Gillies MaireHarley L. Hunt Conseiller généralSharon E. Loder Conseillère généraleFaith A. MacMillan Conseillère généralePatricia A. Shay Conseillère généraleM. Benjamin (Ben) Whalen

Conseiller général

Tide Head, Village de Randy Hunter MaireGary W. Hickey Conseiller généralCatherine L. Johnson-McDavid

Conseillère générale

Patrick Lanteigne Conseiller généralMark St. Onge Conseiller général

Tracadie-Sheila (ville)

Aldéoda Losier MaireRose-Marie Doiron Conseillère généraleMarc Jean Conseiller généralJean-Yves McGraw Conseiller généralDenise McLaughlin Conseillère généraleFernand Paulin Conseiller généralVera Paulin Conseillère générale

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1131 Gazette royale — 11 juillet 2012

Tracy, Village of Dale W. Mowry MayorDale C. Knorr Councillor at LargeCarmen A. Nason Councillor at LargeAndrew V. Phillips Councillor at LargeGloria B. Sprague Councillor at Large

Upper Miramichi, Rural Community of

M. A. Douglas Munn MayorKeith E. Clowater Councillor, Ward 1Grant E. Ross Councillor, Ward 2Chad P. D. Davis Councillor, Ward 3Dustin M. Munn Councillor, Ward 4

Woodstock (town) Arthur L. Slipp MayorAmy Anderson Councillor at LargeTheresa E. Blackburn Councillor at LargeJeff Gordon Bradbury Councillor at LargeBill Hogan Councillor at LargeRandy Leonard Councillor at LargeCatherine L. Sutherland

Councillor at Large

DISTRICT EDUCATION COUNCIL ELECTIONS

School District and Subdistrict Name of Candidate Position

School District Anglophone NorthSubdistrict 1 Micheal Mortlock CouncillorSubdistrict 2 Joe Petersen CouncillorSubdistrict 3 Sheila Rogers CouncillorSubdistrict 4 Mike Coster CouncillorSubdistrict 5 Andy J. Flanagan CouncillorSubdistrict 6 Glenn William

McAllisterCouncillor

Subdistrict 7 Raymond P. Murphy Councillor

School District Anglophone WestSubdistrict 1 Sheila D. Gallagher CouncillorSubdistrict 2 Norma Jean Shaw CouncillorSubdistrict 3 John B. Slipp CouncillorSubdistrict 4 Miriam R. Grant CouncillorSubdistrict 5 Andrew Jason Corey CouncillorSubdistrict 6 David A. Bowen CouncillorSubdistrict 7 James K. Kozlowski CouncillorSubdistrict 8 Ron Buck CouncillorSubdistrict 9 Jane M. Buckley CouncillorSubdistrict 11 Donald A. Gould CouncillorSubdistrict 12 Elizabeth M. Nason CouncillorSubdistrict 13 Mark Noël Councillor

School District Anglophone EastSubdistrict 2 Wayne B. Feindel CouncillorSubdistrict 3 Ian Hebblethwaite CouncillorSubdistrict 4 George Crossman CouncillorSubdistrict 5 Tamara L. Nichol CouncillorSubdistrict 6 Angela C. Lawson CouncillorSubdistrict 7 John W. Gallant CouncillorSubdistrict 8 Harry T. Doyle CouncillorSubdistrict 9 Roberta L. Brewer Councillor

School District Anglophone SouthSubdistrict 1 Wayne A. Spires CouncillorSubdistrict 2 Larry Boudreau CouncillorSubdistrict 3 Robert F. K. Fowler CouncillorSubdistrict 4 Gerald W. Mabey CouncillorSubdistrict 5 Donald Cullinan CouncillorSubdistrict 6 Robert J. McDevitt CouncillorSubdistrict 7 Joanne Gunter CouncillorSubdistrict 8 Charlotte McGill-

PierceCouncillor

Subdistrict 9 Roger H. Nesbitt CouncillorSubdistrict 10 Gary Crossman Councillor

Tracy, Village de Dale W. Mowry MaireDale C. Knorr Conseiller généralCarmen A. Nason Conseiller généralAndrew V. Phillips Conseiller généralGloria B. Sprague Conseillère générale

Upper Miramichi, Communauté rurale d’

M. A. Douglas Munn MaireKeith E. Clowater Conseiller, Quartier 1Grant E. Ross Conseiller, Quartier 2Chad P. D. Davis Conseiller, Quartier 3Dustin M. Munn Conseiller, Quartier 4

Woodstock (ville) Arthur L. Slipp MaireAmy Anderson Conseillère généraleTheresa E. Blackburn Conseillère généraleJeff Gordon Bradbury Conseiller généralBill Hogan Conseiller généralRandy Leonard Conseiller généralCatherine L. Sutherland

Conseillère générale

ÉLECTIONS DE CONSEILS D’ÉDUCATION DE DISTRICT

Districts et sous-districts scolaires

Nom du candidat ou de la candidate Poste

District scolaire Anglophone NorthSous-district 1 Micheal Mortlock ConseillerSous-district 2 Joe Petersen ConseillerSous-district 3 Sheila Rogers ConseillèreSous-district 4 Mike Coster ConseillerSous-district 5 Andy J. Flanagan ConseillerSous-district 6 Glenn William

McAllisterConseiller

Sous-district 7 Raymond P. Murphy Conseiller

District scolaire Anglophone WestSous-district 1 Sheila D. Gallagher ConseillèreSous-district 2 Norma Jean Shaw ConseillèreSous-district 3 John B. Slipp ConseillerSous-district 4 Miriam R. Grant ConseillèreSous-district 5 Andrew Jason Corey ConseillerSous-district 6 David A. Bowen ConseillerSous-district 7 James K. Kozlowski ConseillerSous-district 8 Ron Buck ConseillerSous-district 9 Jane M. Buckley ConseillèreSous-district 11 Donald A. Gould ConseillerSous-district 12 Elizabeth M. Nason ConseillèreSous-district 13 Mark Noël Conseiller

District scolaire Anglophone EastSous-district 2 Wayne B. Feindel ConseillerSous-district 3 Ian Hebblethwaite ConseillerSous-district 4 George Crossman ConseillerSous-district 5 Tamara L. Nichol ConseillèreSous-district 6 Angela C. Lawson ConseillèreSous-district 7 John W. Gallant ConseillerSous-district 8 Harry T. Doyle ConseillerSous-district 9 Roberta L. Brewer Conseillère

District scolaire Anglophone SouthSous-district 1 Wayne A. Spires ConseillerSous-district 2 Larry Boudreau ConseillerSous-district 3 Robert F. K. Fowler ConseillerSous-district 4 Gerald W. Mabey ConseillerSous-district 5 Donald Cullinan ConseillerSous-district 6 Robert J. McDevitt ConseillerSous-district 7 Joanne Gunter ConseillèreSous-district 8 Charlotte McGill-

PierceConseillère

Sous-district 9 Roger H. Nesbitt ConseillerSous-district 10 Gary Crossman Conseiller

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1132 Gazette royale — 11 juillet 2012

DATED at the City of Fredericton, County of York, Province ofNew Brunswick, this 25th day of June, 2012.

Michael P. QuinnMunicipal Electoral Officer

________________

Subdistrict 11 Stephen A. R. Campbell

Councillor

Subdistrict 12 Sherman R. Ross Councillor

School District Francophone Nord-ouestSubdistrict 1 Richard Landry CouncillorSubdistrict 3 Francine Paule Cyr CouncillorSubdistrict 4 Anne-Marie Paradis CouncillorSubdistrict 5 Rino Perron CouncillorSubdistrict 6 Steeve Savoie CouncillorSubdistrict 7 Martine Michaud Councillor

School District Francophone Nord-estSubdistrict 1 Marie-France Maltais CouncillorSubdistrict 2 Mario Pelletier CouncillorSubdistrict 3 Richard Gallant CouncillorSubdistrict 4 Anne-Marie Gammon CouncillorSubdistrict 5 Roger Boudreau CouncillorSubdistrict 6 Jean-Guy Rioux CouncillorSubdistrict 7 Marc Alphonse

LeclairCouncillor

Subdistrict 8 Marcel Basque CouncillorSubdistrict 9 Gerard Robichaud Councillor

School District Francophone SudSubdistrict 1 Roger Martin CouncillorSubdistrict 2 Pamela Doiron CouncillorSubdistrict 3 Suzanne Gagnon CouncillorSubdistrict 4 Gilles Cormier CouncillorSubdistrict 5 Gilles Bourque CouncillorSubdistrict 6 Marc LeBlanc CouncillorSubdistrict 7 Réal Allain CouncillorSubdistrict 8 Gérard Mcken CouncillorSubdistrict 9 Michel Cote CouncillorSubdistrict 10 Willy Wilondja

MayaliwaCouncillor

REGIONAL HEALTH AUTHORITY ELECTIONS

Health Region and Subregion Name of Candidate Position

Health Region A (Vitalité)Subregion A1 Roger Doiron Council MemberSubregion A2 Monique A. LeBlanc Council MemberSubregion A3 Anne Soucie Council MemberSubregion A4 Donald Thériault Council MemberSubregion A5 Christian Mercier Council MemberSubregion A6 Sonia A. Roy Council MemberSubregion A7 Gabriel Godin Council MemberSubregion A8 Paulette Sonier Rioux Council Member

Health Region B (Horizon)Subregion B1 Kathleen M.

McMullenCouncil Member

Subregion B2 Jane Mitton-MacLean Council MemberSubregion B3 Linda G. Forestell Council MemberSubregion B4 Mary Schryer Council MemberSubregion B5 Linda Aitken Council MemberSubregion B6 Jo-Ann Fellows Council MemberSubregion B7 Mike Coster Council MemberSubregion B8 John B. McKay Council Member

FAIT dans la cité de Fredericton, comté d’York au Nouveau-Brunswick, le 25 juin 2012.

Michael P. QuinnDirecteur des élections municipales

________________

Sous-district 11 Stephen A. R. Campbell

Conseiller

Sous-district 12 Sherman R. Ross Conseiller

District scolaire Francophone Nord-ouestSous-district 1 Richard Landry ConseillerSous-district 3 Francine Paule Cyr ConseillèreSous-district 4 Anne-Marie Paradis ConseillèreSous-district 5 Rino Perron ConseillerSous-district 6 Steeve Savoie ConseillerSous-district 7 Martine Michaud Conseillère

District scolaire Francophone Nord-estSous-district 1 Marie-France Maltais ConseillèreSous-district 2 Mario Pelletier ConseillerSous-district 3 Richard Gallant ConseillerSous-district 4 Anne-Marie Gammon ConseillèreSous-district 5 Roger Boudreau ConseillerSous-district 6 Jean-Guy Rioux ConseillerSous-district 7 Marc Alphonse

LeclairConseiller

Sous-district 8 Marcel Basque ConseillerSous-district 9 Gerard Robichaud Conseiller

District scolaire Francophone SudSous-district 1 Roger Martin ConseillerSous-district 2 Pamela Doiron ConseillèreSous-district 3 Suzanne Gagnon ConseillèreSous-district 4 Gilles Cormier ConseillerSous-district 5 Gilles Bourque ConseillerSous-district 6 Marc LeBlanc ConseillerSous-district 7 Réal Allain ConseillerSous-district 8 Gérard Mcken ConseillerSous-district 9 Michel Cote ConseillerSous-district 10 Willy Wilondja

MayaliwaConseiller

ÉLECTIONS DE RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ

Région et sous-régionde la santé

Nom du candidat ou de la candidate Poste

Région de la santé A (Vitalité)Sous-région A1 Roger Doiron Membre du conseilSous-région A2 Monique A. LeBlanc Membre du conseilSous-région A3 Anne Soucie Membre du conseilSous-région A4 Donald Thériault Membre du conseilSous-région A5 Christian Mercier Membre du conseilSous-région A6 Sonia A. Roy Membre du conseilSous-région A7 Gabriel Godin Membre du conseilSous-région A8 Paulette Sonier Rioux Membre du conseil

Région de la santé B (Horizon)Sous-région B1 Kathleen M.

McMullenMembre du conseil

Sous-région B2 Jane Mitton-MacLean Membre du conseilSous-région B3 Linda G. Forestell Membre du conseilSous-région B4 Mary Schryer Membre du conseilSous-région B5 Linda Aitken Membre du conseilSous-région B6 Jo-Ann Fellows Membre du conseilSous-région B7 Mike Coster Membre du conseilSous-région B8 John B. McKay Membre du conseil

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1133 Gazette royale — 11 juillet 2012

SUPERVISOR OF POLITICAL FINANCINGIn accordance with section 36 of the Political Process Financ-ing Act, the annual allowances paid to registered political par-ties for the fiscal year 2010-11 were as follows:

• Progressive Conservative Party of New Brunswick $314,160

• New Brunswick Liberal Association $312,180• New Brunswick New Democratic

Party $33,660

In accordance with section 36 of the Political Process Financ-ing Act, the annual allowances paid to registered political par-ties for the fiscal year 2011-12 were as follows:

• Progressive Conservative Party of New Brunswick $322,420

• New Brunswick Liberal Association $228,326• New Brunswick New Democratic

Party $69,090• Parti Vert N.B. Green Party $30,268• People’s Alliance of New Brunswick $7,896

In accordance with section 32.01 of the Political Process Fi-nancing Act, the annual allowance payable to each of the regis-tered political parties for the fiscal year 2012-13 is as follows:

• Progressive Conservative Party of New Brunswick $322,420

• New Brunswick Liberal Association $228,326• New Brunswick New Democratic

Party $69,090• Parti Vert N.B. Green Party $30,268• People’s Alliance of New Brunswick $7,896

DATED at Fredericton this 27th day of June, 2012.

Michael P. Quinn, Supervisor of Political Financing

CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT POLITIQUESelon l’article 36 de la Loi sur le financement de l’activité poli-tique, les allocations annuelles versées aux partis politiques en-registrés pour l’année financière 2010-11 étaient comme suit :

• Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick 314 160 $

• Association libérale du Nouveau-Brunswick 312 180 $• Nouveau parti démocratique du

Nouveau-Brunswick 33 660 $

Selon l’article 36 de la Loi sur le financement de l’activité poli-tique, les allocations annuelles versées aux partis politiques en-registrés pour l’année financière 2011-12 étaient comme suit :

• Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick 322 420 $

• Association libérale du Nouveau-Brunswick 228 326 $• Nouveau parti démocratique du

Nouveau-Brunswick 69 090 $• Parti Vert N.B. Green Party 30 268 $• Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 7 896 $

Selon l’article 32.01 de la Loi sur le financement de l’activitépolitique, l’allocation annuelle payable à chaque parti politiqueenregistré pour l’année financière 2012-13 est comme suit :

• Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick 322 420 $

• Association libérale du Nouveau-Brunswick 228 326 $• Nouveau parti démocratique du

Nouveau-Brunswick 69 090 $• Parti Vert N.B. Green Party 30 268 $• Alliance des gens du Nouveau-Brunswick 7 896 $

FAIT à Fredericton le 27e juin 2012.

Michael P. Quinn, contrôleur du financement politique

Advan Guard Protocol Inc. Charters Settlement 664231 2012 06 19

RESCA ADVANCED CLEANING TECHNOLOGIES INC. Moncton 664283 2012 06 04

664360 N.B. Corp. Moncton 664360 2012 06 07

Home Alone Pizza Inc. Sackville 664436 2012 06 13

664456 New Brunswick Corp./664456 Nouveau-Brunswick Corp.

Perth-Andover 664456 2012 06 13

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1134 Gazette royale — 11 juillet 2012

Dr. Lauren Wiley Professional Corporation Hanwell 664487 2012 06 15

Dr. Amal Bensaleh-Ratmi Professional Corporation Moncton 664488 2012 06 15

NAGLE INDUSTRIAL SAFETY SERVICES LTD. Quispamsis 664489 2012 06 15

East Coast Athletics Ltd. Saint John 664490 2012 06 15

NeoMedigen, Inc. Fredericton 664491 2012 06 15

Unmanned Innovation, Inc. Fredericton 664492 2012 06 15

Consultant VNO Consulting Inc. Beresford 664494 2012 06 15

Restaurant Villageois Baie Ste. Anne Inc. Baie Ste. Anne 664501 2012 06 15

664502 NB Inc. Irishtown 664502 2012 06 15

DONMAR INDUSTRIES LTD. Beresford 664503 2012 06 15

664504 N.B. Ltd. Oromocto 664504 2012 06 15

LE DELI ACADIEN DELI INC. Petit-Rocher 664505 2012 06 15

664506 N.-B. Inc. Ste-Louise 664506 2012 06 15

TARO ENTERPRISE INC. St. John 664508 2012 06 15

William Goss Professional Corporation Chamcook 664511 2012 06 15

GESTION LARIVIÈRE INC. Moncton 664512 2012 06 15

PEPITO HOLDING INC. Moncton 664513 2012 06 15

LA BOULANGERIE FRANCAISE Ltd. Shediac 664515 2012 06 15

J.P. Beaulieu Machining & Cylinder Repair Inc. DSL de Grand-Sault/LSD of Grand Falls

664516 2012 06 16

Entreprise Coup de Pouce Inc.-Helping Hand Enterprise Inc. Memramcook 664517 2012 06 16

Z X R Storage Inc. Cap-Pelé 664519 2012 06 18

664526 N.B. Inc. Wilmot 664526 2012 06 18

664532 N.B. LTD. Grand Manan 664532 2012 06 18

R&P GROCERY LTD. Welshpool, Île Campobello Island 664533 2012 06 18

DIA RENOVATIONS LTD. Saint John 664534 2012 06 18

NOREMACTAN Tanning & Aesthetics Corp. Saint John 664535 2012 06 18

Century 21 Ludenco Realty Inc. Bathurst 664537 2012 06 18

Green Timber and Veneer Ltd. Saint John 664538 2012 06 18

LES BLEUETTIERES YVES LAROCQUE INC. Lamèque 664540 2012 06 19

DEGRÂCE ARPENTAGES CONSTRUCTIONSURVEYS INC.

Haut-Shippagan 664541 2012 06 19

Beartrap Holdings Inc. Burton 664542 2012 06 19

Aboriginal Precision Products Inc. Beechwood 664546 2012 06 19

R&M Berger Medical Inc. Moncton 664549 2012 06 19

Silingen Atlantic LTD. Moncton 664550 2012 06 19

Lakefront Farms Inc. Lakeville 664551 2012 06 19

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1135 Gazette royale — 11 juillet 2012

Twirly Whirly Curly Fries Inc. Coal Creek 664562 2012 06 19

Distribution Hall Inc. / Hall Distribution Inc. Saint-Isidore 664564 2012 06 19

Krisbrand Enterprises Inc. New Maryland 664571 2012 06 20

664572 NB Inc. Ammon 664572 2012 06 20

Dr. Sarah Caines Professional Corporation Saint John 664574 2012 06 20

DÉPANNEUR FAIRISLE LTÉE Caissie Road 664575 2012 06 20

Norse Sun Industrial & Marine Corp. Saint John 664582 2012 06 20

Les Productions Ciné Atlantik Inc. Tracadie-Sheila 664583 2012 06 20

664584 NB LTD. Woodstock 664584 2012 06 20

GARDERIE TOUCHEATOUT DAYCARE INC. Cormier-Village 664585 2012 06 20

TWINFIELD SERVICES LTD. Saint John 664586 2012 06 20

North Country Farms Ltd. North View 664587 2012 06 20

MGM Fasteners Plus Ltd. Springfield 664590 2012 06 20

Tim Wood Consulting Ltd. Fredericton 664594 2012 06 20

TRH Holdings Ltd. Fredericton 664595 2012 06 21

Dr. Louise Plant Professional Corporation Fredericton 664597 2012 06 21

Atlantic Preferred Seafood Inc. Cormier-Village 664599 2012 06 21

_____________________________________________________

N.Y.C. CONSTRUCTION LTEE 044952 2012 06 20

GILLES J. CORMIER, M.D., F.R.C.S.C., C.S.P.Q. P.C. INC. 505346 2012 06 15

CYR HOLDINGS INC./GESTION CYR INC. 513652 2012 06 15

PRYOR FARMS HOLDINGS LTD. 635513 2012 06 21

DOOLY’S INC. 635689 2012 06 18

658318 N.B. Limited 658318 2012 06 21

TierK Consulting Inc. 658610 2012 06 15

662787 NB INC. 662787 2012 06 14

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1136 Gazette royale — 11 juillet 2012

625316 N.-B. Inc. Domaine Bellerive Inc. 625316 2012 06 18

Ra Ra’s Healthy Stuff Inc. Slendering Measures Inc. 632853 2012 06 15

River Valley Potatoes Inc. Saint John River Valley Potato Inc. 640504 2012 06 20

653137 N.B. Inc. EDMUNDSTON TRUCK STOP INC. 653137 2012 06 19

PURE NIGHTCLUB & LOUNGE INC 657453 NB Inc. 657453 2012 06 19

Frostek Refrigeration Co. Ltd. 661527 N.B. Ltd. 661527 2012 06 21

662219 NB Inc. Grey Cove Veterinary Health Centre Inc. 662219 2012 06 15

Grey Cove Veterinary Health Centre Ltd. 663125 NB Inc. 663125 2012 06 15

MCB Properties Inc. 664261 N.B. Ltd. 664261 2012 06 15

_____________________________________________________

LA VILLA D’AURÉLIE INC. 606879 N.-B. Ltée Acadieville 664547 2012 06 19 La Villa d’Aurélie Inc.

_____________________________________________________

RAE FRASER, LIMITED Moncton 006499 2012 06 15

GROUP NINE PROPERTIES LTD. Bathurst 035241 2012 06 18

SILVER-LINES TRUCK RENTALS LTD. Burtts Corner 048428 2012 06 15

MRC WORKPLACE HEALTH AND SAFETY CONSULTING SERVICES LTD.

Lower Coverdale 057175 2012 06 15

Barazani Imports Ltd. Saint John 620427 2012 06 18

Moravia Management Services Limited Moncton 637493 2012 06 18

ALL WAYS COOL HEATING & COOLING PRODUCTS LTD. Pine Glen 639510 2012 06 19

M.U.T. Ramps Incorporated Rollingdam 642851 2012 06 18

NORTHSHORE STEVEDORING LTD. Dalhousie 646001 2012 06 19

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1137 Gazette royale — 11 juillet 2012

COLEDGE CONSTRUCTION CORPORATION 509170 2012 06 19

628783 N.B. Inc. 628783 2012 06 20

GALLA INTERNET ENTERPRISES INC. 644267 2012 06 19

645381 N.B. INC. 645381 2012 06 15

_____________________________________________________

TECHTRONIC INDUSTRIESCANADA INC.

Canada Matthew R. HiltzFredericton

664419 2012 06 18

The Blue Goose Cattle Company Ltd. Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664460 2012 06 14

Integrity First Telesolutions Inc. Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664461 2012 06 14

Eclipse Advantage Canada Inc. Canada Collin MelansonMoncton

664471 2012 06 14

Toshiba Global Commerce Solutions (Canada) Ltd.Toshiba solutions commercialesglobales (Canada) ltée

Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664482 2012 06 15

MD Practice Software GP Inc. Commandité logiciels de gestion médicale inc.

Canada Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664483 2012 06 15

Les Rôtisseries St-Hubert Canada Inc.St-Hubert Bar-B-Q Canada Inc.

Canada Luc J. ElsligerMoncton

664495 2012 06 15

MAXWELL CLAIMS SERVICES INC. Colombie-Britannique /British Columbia

Steven D. ChristieFredericton

664544 2012 06 18

Cambridge Insurance Brokers (Preston) Ltd.

Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664554 2012 06 19

P.E.I. Bag Co. Ltd. Île-du-Prince-Édouard /Prince Edward Island

Deborah WattonSaint John

664567 2012 06 19

MICHAEL VUKETS & ASSOCIATES LTD.

Ontario Richard Cumming WattSaint John

664568 2012 06 19

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1138 Gazette royale — 11 juillet 2012

Milestone AV Technologies ULC Nouvelle-Écosse /Nova Scotia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664573 2012 06 20

The Cruise Professionals Limited Ontario John D. LaidlawSaint John

664578 2012 06 20

4358376 Canada Inc. Canada John D. LaidlawSaint John

664579 2012 06 20

_____________________________________________________

Tyco Integrated Security Canada,Inc. / Tyco Integrated Security Canada, Inc. 663226 2012 06 15 Sécurité Intégrée Tyco Canada, Inc.

_____________________________________________________

Letko, Brosseau & AssociatesInc. Letko, Brosseau &Associés Inc.

Letko, Brosseau & Associates Inc. /Letko, Brosseau & Associés Inc.

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

664485 2012 06 15

ORKIN CANADA CORPORATION

Orkin Canada Corporation Deborah M. PowerFredericton

664588 2012 06 20

HARBOUR CON-FUSION INC. Saint John 664529 2012 06 18

FREDERICTON MIDGET AAA SCHOLARSHIP FUNDASSOCIATION INC.

Fredericton 664569 2012 06 19

The Pentecostals of Gray Rapids Inc. Gray Rapids 664581 2012 06 20

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1139 Gazette royale — 11 juillet 2012

HK ENTERPRISES Harold Keller Moncton 663888 2012 06 18

Recinos Inter Prices Car Sales Adrian Recinos Pennfield 663988 2012 06 13

Chadican Export-import Mahamat Sougoudji Moncton 664038 2012 06 19

Dairy Creek Farm MILKSTREAM HOLSTEINS LTD.

Searsville 664441 2012 06 13

Delta Rent-A-Car 663152 N.B. LTD. Saint John 664443 2012 06 13

All-Set Transport (2012) 659998 N.B. Ltd. Grand-Sault / Grand Falls 664444 2012 06 13

BV Pools Alltrim Inc. Moncton 664450 2012 06 13

My Faux Chapeau Christine M. Fontaine Lakeville Corner 664452 2012 06 13

Dunn Avenue Productions John P. Edwards Fredericton 664470 2012 06 18

ALYRE ROSS AMENAGEMENTFORESTIER 2012

Alyre Ross Saint-Amateur 664476 2012 06 14

Island Express Krista MacLean Steeves Mountain 664478 2012 06 14

Agence de recouvrement Nord-Est Eric Cormier Caraquet 664479 2012 06 14

Josée Beau Esthetique Josée Richard Saint-Antoine 664480 2012 06 14

Balmoral Maintenance Trevor Dore Moncton 664481 2012 06 14

NEXXUS BEAUTY PRODUCTS Unilever Canada Inc. Saint John 664484 2012 06 15

AMERICREDIT General Motors Financial ofCanada, Ltd./Financière General Motors du Canada Ltée

Moncton 664496 2012 06 15

GM Financial General Motors Financial ofCanada, Ltd./Financière General Motors du Canada Ltée

Moncton 664497 2012 06 15

ROUTE 126 AUTO PARTS GARWA SALES LTD. Rogersville 664498 2012 06 15

LIGHT READS BOOKS Jed Joseph LaLumière Cocagne 664500 2012 06 15

ELITE PAINTING & DECORATING Troy D. Carr Fredericton 664507 2012 06 15

Dynamic Training Centre Pat Corkum Harvey 664509 2012 06 15

Selah Massage Therapy Leah Bryden Fredericton 664510 2012 06 15

Colby Construction Bryan Bradley Moncton 664514 2012 06 15

The Lofts on York 664458 N.B. Inc. Fredericton 664518 2012 06 15

Connie Ullman Dowie Enterprises Connie Dowie St. Thomas 664520 2012 06 18

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1140 Gazette royale — 11 juillet 2012

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMPartnerships and Business Names Registration Act / Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

In relation to the certificate of business name registered on May 22, 2012 under the Act, under the name of “SKIN-E-DIP Skin Care Products”,being file #664011, notice is given that pursuant to s.17 of the Act, the Registrar has ordered that the business name be corrected to read as follows:“SKIN-E-DIP Medicated Ointment”.

Sachez que, relativement à un certificat d’appellation commerciale enregistré le 22 mai 2012 en vertu de la Loi sous le nom de « SKIN-E-DIP SkinCare Products », dont le numéro d’appellation commerciale est 664011, le registraire a ordonné, conformément à l’article 17 de la Loi, que l’ap-pellation commerciale soit corrigée pour qu’elle se lise comme suit : « SKIN-E-DIP Medicated Ointment ».

_____________________________________________________

Bob’s Tax Choice Bob Crossman Moncton 664522 2012 06 18

Travelling Soles Foot Care MaryJean Graham Rexton 664523 2012 06 18

Maison Beth House Huguette LeBlanc Shediac 664524 2012 06 18

Fundy Stonecraft Mason Harris Middleton 664525 2012 06 18

Xtasia Lifestyle & Boutique Madelaine Caissie Moncton 664527 2012 06 18

Moncton Moose Cyber Creative Benjamin David Kelly Riverview 664531 2012 06 20

Total Construction Totale Andy Godin Moncton 664536 2012 06 18

Emily Mercer Events Emily Mercer Cambridge-Narrows 664539 2012 06 18

Gouttière L.M.N Natacha Savoie Evangeline 664543 2012 06 19

EDMUNDSTON TRUCK STOP Vicky Wallace-Godbout Première nation malécite de Madawaska /Madawaska MaliseetFirst Nation

664548 2012 06 19

DéLuc Art Luc Bouchard Shediac River 664552 2012 06 19

HURST CONSTRUCTION Hurst Paving Inc. Saint John 664556 2012 06 20

My Studio Moncton - Mon Studio Moncton

GROUPE LEBOUTHILLIER INC. Moncton 664557 2012 06 19

Place Ryan’s Landing Roland Gallant Parc national du Canada Kouchibouguac /Kouchibouguac National Park of Canada

664558 2012 06 19

Boutique Max & Emma Serge Robichaud Shediac 664563 2012 06 19

R Denny Ground Effects LawnCare Services

Reg Denny Lincoln 664565 2012 06 19

Boutique Bébé tout neuf Kim Thériault Tracadie-Sheila 664577 2012 06 20

ON THE EDGE SAINT JOHNOUTDOOR ADVENTURES

David Byers Saint John 664589 2012 06 20

Beauty Fly Swimwear Karen Richard Saint-Ignace 664593 2012 06 20

EDMUNDSTON TRUCK STOP Vicki Wallace-Godbout Première nation malécite de Madawaska /Madawaska MaliseetFirst Nation

664600 2012 06 21

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1141 Gazette royale — 11 juillet 2012

LAN Silviculture Michael John O’Donnell Nelson Hollow 329021 2012 06 15

East Coast Amateur Golf Championship

NEW BRUNSWICK GOLFASSOCIATION, INC.

Hanwell 351491 2012 06 19

TAZ TIMBER Richard Elliott Wirral 351552 2012 06 18

HERITAGE WROUGHT IRON Paul Fontaine MacDougall Settlement 351645 2012 06 18

JP Logging Jonathan Costain Benton 351834 2012 06 19

Gary Estabrooks’ Auto Service Gary Estabrooks Sackville 351864 2012 06 15

COIFFURE DIVA Johanne Bujold Campbellton 352857 2012 06 20

THE POTTING SHED Lori Garland Quispamsis 600353 2012 06 19

JULIA’S UPHOLSTERY ETC. Julia Howe French Lake 600756 2012 06 14

McFADDEN LIGHT ELECTRIC Donald G. McFadden Riverview 600886 2012 06 18

Wall Construction Services 600899 N.B. Inc. New Maryland 600900 2012 06 20

WINDOW WORLD Economy Building Products Inc. Moncton 602289 2012 06 18

Nick Blackwell Trucking Nicholas Blackwell Yoho 628013 2012 06 14

RE/MAX GROUP FOUR REALTY 628377 NB INC. Fredericton 629975 2012 06 19

Paul Miller’s Service Centre Paul Miller Minto 630956 2012 06 18

Teepee Mik Maq Crafts Anne MacDonald Bouctouche Reserve 631028 2012 06 19

Community Phsychology Resource Luanne Mann Campbellton 631142 2012 06 21 Center

Ecoability Robert Donald Cameron Moncton 631204 2012 06 18

TRIM WAY LANDSCAPING Christopher Brian LeBlanc Riverview 631597 2012 06 15

Professionals Association ofChinese in New Brunswick

Du WeichangeMing ZhongYanjun Wang

Fredericton 631614 2012 06 19

Les Entreprises Mario Robichaud Mario Robichaud Alcida 631660 2012 06 18

West Side Medical Clinic HARBOUR CITY MEDICAL GROUP P.C. INC.

Saint John 631666 2012 06 19

North End Afterhours Clinic HARBOUR CITY MEDICAL GROUP P.C. INC.

Saint John 631667 2012 06 19

McAllister Afterhours Clinic HARBOUR CITY MEDICAL GROUP P.C. INC.

Saint John 631668 2012 06 19

Saint John Afterhours Clinic HARBOUR CITY MEDICAL GROUP P.C. INC.

Saint John 631671 2012 06 19

K.V. Afterhours Clinic HARBOUR CITY MEDICAL GROUP P.C. INC.

Saint John 631672 2012 06 19

ELLIE’S KITCHEN Eleanor J. Wormell Napan 631699 2012 06 19

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 26: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1142 Gazette royale — 11 juillet 2012

Thinking Fresh Services Darryl Johnstone Fredericton 631836 2012 06 17

PARADIS DES CHIENS Janice Vautour Dieppe 631872 2012 06 18

Billy’s Bottle Exchange, Salvage & William R. Poirier Dalhousie 631928 2012 06 18 Repair Shop

M. LeBlanc Renovations Michel LeBlanc Rogersville 631937 2012 06 19

ALL WORLD MOVING & STORAGE

500323 (N.B.) LTD. Saint John 632319 2012 06 15

EAST COAST WALLACE MOVING AND STORAGE

500323 (N.B.) LTD. Saint John 632320 2012 06 15

THE LIGHTING DESIGN CENTRE 631919 NB INC. Moncton 632384 2012 06 14

Honda Financial Services HONDA CANADA FINANCE INC.

Saint John 632593 2012 06 15

Aesthetique by/par Joanne Joanne Doucet-Barna Fredericton 633322 2012 06 15

_____________________________________________________

Total Construction Totale Moncton 618180 2012 06 18

Delta Rent-A-Car Saint John 632380 2012 06 13

Schering-Plough Animal Health/Schering-Plough Sante Animale Saint John 644515 2012 06 19

Twirly Whirly Curly Fries Chipman 653232 2012 06 19

Home Alone Pizza Sackville 653865 2012 06 20

GM Financial Moncton 655880 2012 06 15

AmeriCredit Moncton 655881 2012 06 15

DIA RENOVATIONS Saint John 657420 2012 06 18

GRACE EDUCATION & IMMIGRATION CONSULTING Quispamsis 661436 2012 06 19

Island Express Moncton 662510 2012 06 14

EDMUNDSTON TRUCK STOP Première nation malécite de Madawaska /Madawaska MaliseetFirst Nation

664548 2012 06 21

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 27: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1143 Gazette royale — 11 juillet 2012

Wybou Pitre Business Consultants Deborah Ann WybouJoseph Yvon Pitre

Fredericton 664300 2012 06 20

QCC - Quality Customer Care Tammy Marie AndersonDenise Marie Prosser

Hartland 664417 2012 06 20

Theatre Smeatre Summer Programme Julia BelliveauPatrick BelliveauCarter BelliveauNicole Belliveau

Sussex 664429 2012 06 18

Radon Safety NB Brian D. RichMark G. Stevens

Riverview 664499 2012 06 15

clinic Physio Logic Julie Ruest BendouahTarik Bendouah

Grand-Sault / Grand Falls 664559 2012 06 19

_____________________________________________________

Old Gold Auto Restoration Peter Michael LeretteIan Sidney Harborne

Upper Sackville 600964 2012 06 18

General Electric Canada Management Services

GE Canada Management ServicesCompanyGeneral Electric CanadaCompany / Compagnie deGénérale Électrique du Canada

Stewart McKelvey Corporate Services(NB) Inc.

610681 2012 06 20

Janet’s Jerky Janet MacLeodNigel MacLeod

Salisbury 631930 2012 06 18

_____________________________________________________

QQ Bubble Tea Saint John 643487 2012 06 14

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-lution de société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 28: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1144 Gazette royale — 11 juillet 2012

General Electric Canada Management Services

General ElectricCanada Company

General Electric CanadaCompany/Compagnie de GénéraleÉlectrique du Canada

610681 2012 06 20

Altus Geomatics LimitedPartnership

Saint JohnCorporate Services(NB) Inc.Saint John

Alberta Stewart McKelvey 632046 2012 06 15

_____________________________________________________

Intragas Energy, Limited Partnership Québec / Quebec Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

602088 2012 06 19

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of member-ship of partnership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Retiring Partners Incoming Partners Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Associés sortants Nouveaux associés référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limitedpartnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale aété déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

Page 29: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1145 Gazette royale — 11 juillet 2012

NOTICE OF INTENT TO FORFEIT AVIS D’INTENTION DE CONFISCATIONThe department has monies held in trust resulting from real propertytax sales conducted during the period of 1975 to 2006 inclusive.PUBLIC NOTICE is hereby given that in accordance with theprovisions of section 12 of the Real Property Tax Act, unless a claim isreceived within 30 days from the date of this notice, it is the intent toforfeit such monies held in trust to the Crown in right of the Province.

Le Ministère détient des fonds en fiducie provenant de ventes pour non-paiement d’impôt foncier menées de 1975 à 2006 inclusivement.AVIS EST DONNÉ par les présentes, conformément aux dispositionsde l’article 12 de la Loi sur l’impôt foncier, qu’il est prévu, sauf si uneréclamation est reçue dans les 30 jours suivant la date du présent avis, deconfisquer ces fonds détenus en fiducie au profit de la Couronne du chefde la province.

Assessed Owner / Propriétaire imposé Property Location Lieu du bien Date of Sale Date de vente

PropertyAccount No. /Numéro de compte des biens

P.I.D./N.I.D.

Succession de Mrs. Eugenie Hebert Estate

Route 480Parish of Acadieville

Route 480Paroisse d’Acadieville

February 1975 Février 1975 02334811 25000647

John Rybka Mill Creek RoadParish of Saint Charles

Chemin Mill CreekParoisse de Saint Charles

February 1975 Février 1975 02370126 25210212

Succession de William Jones Estate Jones RoadParish of Weldford

Chemin JonesParoisse de Weldford

February 1975 Février 1975 02467070 25083510

Walter Ferguson 59 Babineau PlaceParish of Dundas

59, place BabineauParoisse de Dundas

February 1975 Février 1975 02487703 25099060

Nap J. Ouellette 940 Highway, ShemogueParish of Botsford

Route 940, ShemogueParoisse de Botsford

June 1980 Juin 1980 02052891 00839985

Buctouche Welding & Steel 116 Evangeline StreetParish of Wellington

116, rue EvangelineParoisse de Wellington

November 1981 Novembre 1981 02423149 25055526

Succession d’Albert Richard Estate Desherbiers RoadParish of Saint-Louis

Chemin DesherbiersParoisse de Saint-Louis

June 1984 Juin 1984 02353857 25013137

Succession de Francois F. Comeau Estate

Saint Charles Nord RoadParish of Saint Charles

Chemin Saint Charles nordParoisse de Saint Charles

June 1985 Juin 1985 02369793 25208885

Succession de Xavier Chenard Estate

307 Boulevard Saint Pierre EastVillage of Caraquet

307, boulevard Saint Pierre estVillage de Caraquet

June 1986 Juin 1986 03261011 N/A / S/O

Succession de Marguerite Gallant Estate

De la Côte RoadParish of Dundas

Chemin de la CôteParoisse de Dundas

November 1986 Novembre 1986 02502260 25111147

Joseph Henri Grenier Beckwith RoadParish of Weldford

Chemin BeckwithParoisse de Weldford

June 1987 Juin 1987 02475447 25089822

Succession de Clen Edward Estate Church StreetVillage of Rexton

Rue ChurchVillage de Rexton

June 1987 Juin 1987 02557833 25152067

David Someone and/et Robin Someone

Silvertown RoadParish of Weldford

Chemin SilvertownParoisse de Weldford

February 1989 Février 1989 02474386 25077991

Russell Richard and/et Diannia Richard

Beers Back RoadParish of Weldford

Chemin Beers BackParoisse de Weldford

February 1989 Février 1989 02478615 25091604

Audrey Carlin Roberts RoadParish of Weldford

Chemin RobertsParoisse de Weldford

October 1989 Octobre 1989 02475968 25090150

Arno Jordan Wilson DriveParish of Richibucto

Promenade WilsonParoisse de Richibucto

June 1990 Juin 1990 02536803 25201708

Succession de Meleme Poirier Estate

14 Block RoadParish of Acadieville

14, chemin BlockParoisse d’Acadieville

October 1990 Octobre 1990 02337704 25003153

Monica Perkuinas Route 126Parish of Harcourt

Route 126Paroisse d’Harcourt

October 1990 Octobre 1990 02383959 25029810

Department of Finance Ministère des Finances

Page 30: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1146 Gazette royale — 11 juillet 2012

Succession de Jessie P. Dunn Estate Route 127Parish of Harcourt

Route 127Paroisse d’Harcourt

October 1990 Octobre 1990 02384298 25030123

Douglas Logan Dollard Settlement RoadParish of Saint Mary

Chemin Dollard SettlementParoisse de Saint Mary

October 1990 Octobre 1990 02412481 25272451

Succession de Joseph A. Melanson Estate

Route 535, CormiervilleParish of Dundas

Route 535, CormiervilleParoisse de Dundas

October 1990 Octobre 1990 02496362 25106469

Succession d’Edmond Poirier Estate

Babineau RoadParish of Dundas

Chemin BabineauParoisse de Dundas

October 1990 Octobre 1990 02519398 25245051

H. M. Dignam Corp. Ltd. 828 Des Dallaires RoadParish of Saint Mary

828, chemin des DallairesParoisse de Saint Mary

June 1991 Juin 1991 02412651 25272626

Reg Daigle Desherbiers RoadParish of Saint-Louis

Chemin DesherbiersParoisse de Saint-Louis

June 1992 Juin 1992 02360189 25203373

Diana Dignam Route 126, AdamsvilleParish of Harcourt

Route 126, AdamsvilleParoisse d’Harcourt

June 1992 Juin 1992 02382741 25028713

Wilhelm Menzer St. Lazare RoadParish of Saint Mary

Chemin St. LazareParoisse de Saint Mary

June 1992 Juin 1992 02412457 25272428

Succession de Jude Richard Estate Saint-Athanase RoadParish of Acadieville

Chemin Saint-AthanaseParoisse d’Acadieville

June 1992 Juin 1992 03943508 25204256

Succession de Joseph Martin Sr. Estate

Route 117, EscuminacParish of Carleton

Route 117, EscuminacParoisse de Carleton

October 1992 Octobre 1992 03947243 25248329

Succession de Peter Robichaud Estate

Route 118, EscuminacParish of Carleton

Route 118, EscuminacParoisse de Carleton

October 1992 Octobre 1992 03947277 25248352

Succession d’Howard Allen Estate Route 119, EscuminacParish of Carleton

Route 119, EscuminacParoisse de Carleton

October 1992 Octobre 1992 03947324 25248436

Succession d’Ellen Beattie Estate 60 South Kouchibouguac RoadParish of Carleton

60, chemin Kouchibouguac sudParoisse de Carleton

October 1992 Octobre 1992 03973498 25153784

The Reid Pulpwood Co. Ltd. Galloway RoadParish of Richibucto

Chemin GallowayParoisse de Richibucto

October 1992 Octobre 1992 04053958 25258799

Therese Melanson Lake Road, Coal BranchParish of Harcourt

Chemin Lake, Coal BranchParoisse d’Harcourt

June 1993 Juin 1993 02387181 25020850

Faye Marilyn Robichaud, Administratix of / administratix de Francois Robichaud

424 Route 535Parish of Wellington

424, route 535Paroisse de Wellington

June 1994 Juin 1994 02426325 25058173

Succession de George Sawyer Estate et al

Renaud RoadParish of Wellington

Chemin RenaudParoisse de Wellington

May 2000 Mai 2000 03541330 25234584

Succession de Docity Lirette Estate White Settlement RoadParish of Dundas

Chemin White SettlementParoisse de Dundas

May 2000 Mai 2000 03566013 25245390

Diane Morin Route 480, Trout BrookParish of Saint-Louis

Route 480, Trout BrookParoisse de Saint-Louis

November 2003 Novembre 2003 02353792 25344748

Succession de J. D. Phinney Estate Saint-Athanase RoadParish of Acadieville

Chemin Saint-AthanaseParoisse d’Acadieville

November 2003 Novembre 2003 04474285 25348830

Succession de Raymond J. Cook Estate

Route 11Parish of Glenelg

Route 11Paroisse de Glenelg

May 2004 Mai 2004 04922911 40073439

Anna Fraser and/et Margaret Cain 28 Brait StreetVillage of Rexton

28, rue BraitVillage de Rexton

November 2004 Novembre 2004 02558229 25146747

Succession de Joseph Surette Estate Gerard RoadParish of Dundas

Chemin GerardParoisse de Dundas

June 2005 Juin 2005 02493314 25108051

Germaine Tremblay and/et Noel Tremblay

530 Saint Augustin RoadParish of Harcourt

580, chemin Saint AugustinParoisse d’Harcourt

February 1999 Février 1999 02383006 25028945

James Royden Patrick Flora Route 480Parish of Saint-Louis

Route 480Paroisse de Saint-Louis

October 1989 Octobre 1989 02352131 25261678

Page 31: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1147 Gazette royale — 11 juillet 2012

Succession d’Olybruis Constantineau Estate

Saint Wilfred RoadParish of Lagaceville

Chemin Saint WilfredParoisse de Lagaceville

October 1985 Octobre 1985 02595093 N/A / S/O

Succession de Wilfred Brown Estate

O’Hearne Road, WeldfieldParish of Douglastown

Chemin O’Hearne, WeldfieldParoisse deDouglastown

February 1986 Février 1986 02677332 N/A / S/O

Succession de John Thibodeau Estate

West Eel River RoadParish of Hardwicke

Chemin Eel River ouestParoisse d’Hardwicke

November 1986 Novembre 1986 02693859 40228793

Succession d’Elizabeth Howe Estate

370 Beaverbrook RoadCity of Miramichi

370, chemin BeaverbrookVille de Miramichi

November 1986 Novembre 1986 02807929 40175739

Succession de John Townley Estate Richard Settlement RoadParish of Rogersville

Chemin Richard SettlementParoisse de Rogersville

February 1988 Février 1988 02786571 40152324

Succession d’Albert Boudreau Estate

27 Commerciale StreetVillage of Rogersville

27, rue CommercialeVillage de Rogersville

February 1988 Février 1988 02791542 40161374

Gaythorne Estates Ltd. 21 O’Toole CrescentCity of Miramichi

21, croissant O’TooleVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475440 40278582

Gaythorne Estates Ltd. O’Toole CrescentCity of Miramichi

Croissant O’TooleVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475466 40278582

Gaythorne Estates Ltd. 20 O’Toole CrescentCity of Miramichi

20, croissant O’TooleVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475474 40221301

Gaythorne Estates Ltd. 8 O’Toole CrescentCity of Miramichi

8, croissant O’TooleVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475482 40278608

Gaythorne Estates Ltd. O’Toole CrescentCity of Miramichi

Croissant O’TooleVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475490 40278574

Gaythorne Estates Ltd. Patterson DriveCity of Miramichi

Promenade PattersonVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475505 40278558

Gaythorne Estates Ltd. Patterson DriveCity of Miramichi

Promenade PattersonVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475513 40278566

Gaythorne Estates Ltd. Patterson DriveCity of Miramichi

Promenade PattersonVille de Miramichi

February 1988 Février 1988 03475547 40278525

Succession de Benjamin Stymest Estate

Point Escuminac RoadParish of Carleton

Chemin Point EscuminacParoisse de Carleton

June 1988 Juin 1988 02684127 40076416

Succession de Daniel Sheenan Estate

North Barnaby River RoadParish of Nelson

Chemin Barnaby River nordParoisse de Nelson

June 1988 Juin 1988 02723191 40097446

Succession de Benjamin Coughlin Sr. Estate

20 Barnetville Road WestParish of Blackville

20, chemin Barnetville ouestParoisse de Blackville

November 1988 Novembre 1988 02614449 40023608

Succession de Michael Bransfield Estate

Route 117, EscuminacParish of Hardwicke

Route 117, EscuminacParoisse d’Hardwicke

November 1988 Novembre 1988 02684698 40238750

Succession de Lucille Mazerolle Estate

Robinson Brook RoadParish of Alnwick

Chemin Robinson BrookParoisse d’Alnwick

June 1989 Juin 1989 02582707 40230328

P. M. Barnato and/et M. A. Carney Bettsburg RoadParish of Blissfield

Chemin BettsburtParoisse de Blissfield

June 1989 Juin 1989 02638760 40042327

Succession de Cecil B. Rushton Estate

Route 480, Acadie SidingParish of Rogersville

Route 480, Acadie SidingParoisse de Rogersville

October 1989 Octobre 1989 02336392 25001942

Milton McKinley Douglasfield RoadCity of Miramichi

Chemin DouglasfieldVille de Miramichi

June 1990 Juin 1990 02646470 40264400

Harry S. Knickle Route 117, Miramichi BayParish of Hardwicke

Route 117, Miramichi BayParoisse d’Hardwicke

June 1990 Juin 1990 02693891 40252587

Succession d’Abraham McInnis Estate

2491 Route 118Parish of Nelson

2491, route 118Paroisse de Nelson

June 1990 Juin 1990 02715740 40099202

Page 32: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1148 Gazette royale — 11 juillet 2012

Succession de Joseph J. Duplessie Estate

East Eel River Bridge RoadParish of Hardwicke

Chemin East Eel River BridgeParoisse d’Hardwicke

June 1990 Juin 1990 03716642 N/A / S/O

Succession de Clements K. Smith Estate

Route 625, Parkers RidgeParish of Stanley

Route 625, Parkers RidgeParoisse de Stanley

February 1991 Février 1991 00703828 75182311

Succession de Margaret Price Estate Main Street, BlackvilleVillage of Blackville

Rue Main, Blackville Village de Blackville

June 1992 Juin 1992 02630136 N/A / S/O

Succession de Thomas McCullam Estate

Wallace RoadParish of Glenelg

Chemin WallaceParoisse de Glenelg

November 1993 Novembre 1993 02680157 40074189

Succession de John Brown Estate Route 117, EscuminacParish of Hardwicke

Route 117, EscuminacParoisse d’Hardwicke

October 1995 Octobre 1995 04298590 40307027

Succession de Robert Barry Estate South Bartholomew RoadVillage of Blackville

Chemin Bartholomew sudVillage de Blackville

August 1996 Août 1996 02631166 40034605

Succession de Lloyd Barry Estate 15 Station StreetVillage of Blackville

15, rue StationVillage de Blackville

August 1996 Août 1996 03600744 40036014

Succession d’Howard Dawson Estate

Semiwagan RoadParish of Nelson

Chemin SemiwaganParoisse de Nelson

March 1997 Mars 1997 02716885 40095416

Succession d’Ida M. Scott Estate Route 425Parish of Northesk

Route 425Paroisse de Northesk

May 2000 Mai 2000 02754671 40127698

Leonard M. Burns and/et Thomas H. Burns

Route 420Parish of Southesk

Route 420Paroisse de Southesk

May 2000 Mai 2000 02770554 40136533

Succession de Calvis Walsh and/et Susan Walsh Estate

Sutton RoadCity of Miramichi

Chemin SuttonVille de Miramichi

June 2002 Juin 2002 02719689 40222341

Succession de Dr. G. J. Sproul Estate

Hudson RoadParish of Glenelg

Chemin HudsonParoisse de Glenelg

May 2004 Mai 2004 02677277 40072043

Succession de Theresa Wade Estate 215 Gladstone AvenueCity of Miramichi

215, avenue GladstoneVille de Miramichi

May 2004 Mai 2004 02809719 40177636

Succession de Gordon Blakely Estate

Weldfield RoadParish of Glenelg

Chemin WeldfieldParoisse de Glenelg

November 2004 Novembre 2004 02678037 40072803

Succession de Matthias King Estate Douglasfield RoadParish of Glenelg

Chemin DouglasfieldParoisse de Glenelg

November 2004 Novembre 2004 02678299 40073066

Succession de William Benoit Estate

Bellefond RoadParish of Newcastle

Chemin BellefondParoisse de Newcastle

November 2004 Novembre 2004 02727991 40113375

Herman Gifford Route 430Parish of Northesk

Route 430Paroisse de Northesk

April 2005 Avril 2005 02768612 40336000

Succession d’Edward John Brown Estate

Route 11 Parish of Alnwick

Route 11 Paroisse d’Alnwick

April 2006 Avril 2006 02587082 40245185

Succession d’Edward John Brown Estate

Route 12Parish of Alnwick

Route 12Paroisse d’Alnwick

April 2006 Avril 2006 02588208 N/A / S/O

Succession de James Kenneth Russell Estate

James Savage RoadParish of Newcastle

Chemin James SavageParoisse de Newcastle

February 1999 Février 1999 02734029 40101321

John L. Daigle Melanson BrookParish of Bathurst

Melanson BrookParoisse de Bathurst

February 1975 Février 1975 03175252 20308409

Succession de Jean Noel Estate Route 160Parish of Allardville

Route 160Paroisse d’Allardville

November 1982 Novembre 1982 03164617 20298782

Stephen A’Hearn Route 11, South PokeshawParish of New Brandon

Route 11, South PokeshawParoisse de New Brandon

June 1983 Juin 1983 02917847 20077772

Succession de Joseph Pierre Lanteigne Estate

Route 113, Point-CanotParish of Shippegan

Route 113, Point-CanotParoisse de Shippegan

October 1983 Octobre 1983 03028772 20180642

George Young 2258 Saint Mary AvenueCity of Bathurst

2258, avenue Saint MaryVille de Bathurst

February 1985 Février 1985 02852364 20016655

Ronald Coffin Route 11Village of Grande-Anse

Route 11Village de Grande-Anse

June 1985 Juin 1985 02928709 20089397

Page 33: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1149 Gazette royale — 11 juillet 2012

7Sachez, en vertu du paragraphe 214(2) de la Loi sur les com-pagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2, que le Ministre adélivré un premier permis à CONCENTRA FINANCIAL SER-VICES ASSOCIATION/ASSOCIATION DE SERVICES FI-NANCIERS CONCENTRA en date du 7 juin 2012.

Le surintendant des compagnies de prêt et de fiduciePierre LeBlanc, c.a.

Ministère de la Justiceet du Procureur général

Public notice is hereby given pursuant to subsection 214(2) ofthe Loan and Trust Companies Act, chapter L-11.2, that theMinister has issued a first licence to CONCENTRA FINAN-CIAL SERVICES ASSOCIATION/ASSOCIATION DE SER-VICES FINANCIERS CONCENTRA effective June 7, 2012.

Pierre LeBlanc, CASuperintendent of Loan and Trust Companies

Ronald Turner and/et Kathryn Turner

Route 134Parish of Allardville

Route 134Paroisse d’Allardville

October 1985 Octobre 1985 03165728 20299939

Succession d’Annie Kenny Estate 375 Riverside DriveCity of Bathurst

375, promenade RiversideVille de Bathurst

June 1986 Juin 1986 02843632 20007829

Herbert Carrol Peacock and/et Shirley Marie Peacock

Route 134Parish of Allardville

Route 134Paroisse d’Allardville

November 1986 Novembre 1986 03168077 20302527

Roland Doiron and/et Gisele Doiron 219 Principale StreetVillage of Pointe-Verte

219, rue PrincipaleVillage de Pointe-Verte

February 1988 Février 1988 03134599 20279519

Succession de Clifford Vienneau Estate

Beresford, Chamberlain Settlement RoadParish of Bathurst

Beresford, cheminChamberlain SettlementParoisse de Bathurst

February 1989 Février 1989 03183776 20317137

Derek Stairs Route 340Parish of Paquetville

Route 340Paroisse de Paquetville

February 1994 Février 1994 02956346 20574299

Succession de Luc L. Brideau Estate

Route 160Parish of Allardville

Route 160Paroisse d’Allardville

February 1994 Février 1994 03167411 20301792

Succession d’Alphonse Mazerolle Estate

550 Route 355Parish of Inkerman

550, route 355Paroisse d’Inkerman

March 1997 Mars 1997 02894667 20056669

Succession de F. Sivret Estate Route 113, MiscouParish of Shippegan

Route 113, MiscouParoisse de Shippegan

November 2003 Novembre 2003 03013298 20164851

Succession d’Y.P. Boudreau Estate Des Buttes RoadVillage of Bertrand

Chemin des ButtesVillage de Bertrand

November 2003 Novembre 2003 04142333 20622148

Succession de Roy Collings Estate 1834 Bridge StreetCity of Bathurst

1834, rue BridgeVille de Bathurst

May 2004 Mai 2004 02849620 20013884

Robert Joseph Talbot Sr. and/et Elaine Holden Talbot

Route 350, Rang-Saint-GeorgesParish of Paquetville

Route 350, Rang-Saint-GeorgesParoisse de Paquetville

April 2005 Avril 2005 02949909 20107082

Mildred Stever 1383 Saint Theresa CrescentParish of Bathurst

1383, croissant Saint TheresaParoisse de Bathurst

November 2005 Novembre 2005 02857738 20022125

Waldo Bosca and/et Percy Miller Route 134, Bass RiverCity of Bathurst

Route 134, Bass RiverVille de Bathurst

November 2005 Novembre 2005 03178878 20312112

Caisse Populaire Chaleur Ltee and/et Banque Royale Du Canada

62 Allee de la CoteParish of Beresford

62, allée de la CoteParoisse de Beresford

November 2005 Novembre 2005 03117288 20272423

Leo Paul Cormier and/et Nelda Cormier

Route 11Parish of Bathurst

Route 11Paroisse de Bathurst

February 1987 Février 1987 03178438 20311676

Contact: Deborah RankineTelephone: 1-800-669-7070www.gnb.ca

Contacter : Deborah RankineTéléphone : 1-800-669-7070www.gnb.ca

Richard McCulloughProvincial Tax Commissioner

Le commissaire de l’impôt provincial,Richard McCullough

Department of Justiceand Attorney General

Page 34: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1150 Gazette royale — 11 juillet 2012

FORM MC-103

NB ENERGY AND UTILITIES BOARD

NOTICE OF APPLICATION FOR A MOTOR CARRIER LICENSE

Take Notice that the NB Energy and Utilities Board shall on the7th day of August, 2012 (hereafter referred to as the “ReviewDate”) review an application filed by 100921 P.E.I Inc. O/AAdvance Shuttle Service, 43 Jenkins Avenue, Summerside,PEI, C1N 1E3, a license to operate a public motor bus asfollows:

For the carriage of passengers and their baggage as a sched-ule service to and from PEI, NB, and NS with the right tostop in Port Elgin, Aulac and Sackville.

Any person wishing to object to the granting of this applicationshall:1. File with the Board:

(a) a notice of objection to the application at least 7 daysprior to the “Review Date”, and

(b) one day prior to the “Review Date” a written statementsetting out in full the reasons why the application shouldbe denied together with any relevant documentaryevidence.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant by:(a) personal service at least 7 days prior to the “Review

Date”, or(b) prepaid registered mail at the address below, posted at

least 10 days prior to the “Review Date”.

ADDRESSES FOR SERVICE:Applicant:

________________

FORM MC-103

NB ENERGY AND UTILITIES BOARD

NOTICE OF APPLICATION FOR A MOTOR CARRIER LICENSE

Take Notice that the NB Energy and Utilities Board shall on the7th day of August, 2012 (hereafter referred to as the “ReviewDate”) review an application filed by 662452 NB Ltd O/AUnique Limousine & Car Service, 34 Carsdale Court,

David Anderson43 Jenkins AvenueSummerside, PEIC1N 1E3

NB Energy and Utilities BoardSuite 140015 Market SquareP.O. Box 5001Saint John, N.B.E2L 4Y9

NB Energy andUtilities Board

FORMULE MC-103

COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU N.-B.

AVIS DE DEMANDE DE PERMIS DE TRANSPORT ROUTIERS

Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services pu-blics du Nouveau-Brunswick révisera la demande fait par100921 P.E.I Inc. O/A Advance Shuttle Service, 43, avenueJenkins, Summerside (Î.-P.-É.), C1N 1E3, le 7 août 2012 (ci-après appelée la « date de révision ») pour un permis d’exploiterun autocar public comme suit :

Pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyagenolisés à destination, et en provenance de L’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse avecle droit d’arrêter à Port Elgin, Aulac et Sackville.

Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présentedemande devra :1. Déposer auprès de la Commission

a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avantla date de révision, et

b) une opposition par écrit au moins un jour avant la date derévision, énonçant tous les motifs pour lesquels la de-mande devrait être refusée, accompagnée de toutepreuve documentaire pertinente.

2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’oppositiona) par signification à personne au moins 7 jours avant la

date de révision, oub) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé af-

franchi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date derévision.

ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION :Requérant :

________________

FORMULE MC-103

COMMISSION DE L’ÉNERGIE ET DES SERVICES PUBLICS DU N.-B.

AVIS DE DEMANDE DE PERMIS DE TRANSPORT ROUTIERS

Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services pu-blics du Nouveau-Brunswick révisera la demande fait par662452 NB Ltd O/A Unique Limousine & Car Service,34, cour Carsdale, Moncton (N.-B.), E1G 5G2, le 7 août 2012

David Anderson43, avenue JenkinsSummerside (Î.-P.-É.)C1N 1E3

Commission de l’énergie etdes services publicsdu Nouveau-BrunswickBureau 140015, Market SquareC.P. 5001Saint John (N.-B.)E2L 4Y9

Commission de l’énergie et desservices publics du N.-B.

Page 35: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1151 Gazette royale — 11 juillet 2012

Moncton, NB, E1G 5G2, a license to operate a public motorbus as follows:

For the carriage of passengers and their baggage as a charteroperation only, to, from and between all points in the prov-ince of New Brunswick with the right to extend into other ju-risdictions authorised thereby and the reverse thereof.

Any person wishing to object to the granting of this applicationshall:1. File with the Board:

(a) a notice of objection to the application at least 7 daysprior to the “Review Date”, and

(b) one day prior to the “Review Date” a written statementsetting out in full the reasons why the application shouldbe denied together with any relevant documentaryevidence.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant by:(a) personal service at least 7 days prior to the “Review

Date”, or(b) prepaid registered mail at the address below, posted at

least 10 days prior to the “Review Date”.

ADDRESSES FOR SERVICE:Applicant:

NOTICE OF RULEThe making of amendments to:

• National Instrument 21-101 Marketplace Operation(NI 21-101), including Form 21-101F1 InformationStatement Exchange or Quotation and Trade ReportingSystem, Form 21-101F2 Initial Operation Report Alter-native Trading System, Form 21-101F3 Quarterly Reportof Marketplace Activities and Form 21-101F5 Initial Op-eration Report for Information Processor, and Compan-ion Policy 21-101CP;

• National Instrument 23-101 Trading Rules (NI 23-101)and Companion Policy 23-101CP; and

• Multilateral Instrument 11-102 Passport System.(together, the Amendments)

Ministerial ConsentOn May 16th, 2012, the Minister of Justice and Attorney Gen-eral consented to the making of the above-noted Amendments.

Heinz J. Luethi662452 NB Ltd O/A Unique Limousine & Car Service34 Carsdale CourtMoncton, NBE1G 5G2

NB Energy and Utilities BoardSuite 140015 Market SquareP.O. Box 5001Saint John, N.B.E2L 4Y9

New BrunswickSecurities Commission

(ci-après appelée la « date de révision ») pour un permis d’ex-ploiter un autocar public comme suit :

Pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyagenolisés seulement, à destination, et en provenance de tous lespoints de la province du Nouveau-Brunswick, et entre tousces points avec privilège d’acheminement vers d’autres ter-ritoires, selon l’autorisation accordée, et le trajet de retour.

Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présentedemande devra :1. Déposer auprès de la Commission

a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avantla date de révision, et

b) une opposition par écrit au moins un jour avant la date derévision, énonçant tous les motifs pour lesquels la de-mande devrait être refusée, accompagnée de toutepreuve documentaire pertinente.

2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’oppositiona) par signification à personne au moins 7 jours avant la

date de révision, oub) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé af-

franchi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date derévision.

ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION :Requérant :

AVIS DE RÈGLEL’établissement des modifications à :

• la Norme canadienne 21-101 sur le fonctionnement dumarché (NC 21-101), y compris l’Annexe 21-101A1Fiche d’information, l’Annexe 21-101A2 Rapport initialsur le fonctionnement du système de négociation paral-lèle, l’Annexe 21-101A3 Rapport d’activité trimestrieldu système de négociation parallèle et l’Annexe21-101A5 Rapport initial sur le fonctionnement del’agence de traitement de l’information, ainsi que l’ins-truction complémentaire s’y rapportant;

• la Norme canadienne 23-101 sur les règles de négociation(NC 23-101) et l’Instruction complémentaire s’y rappor-tant; et

• la Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport.(ensemble, les modifications)

Consentement ministérielLe 16 mai 2012, la ministre de la Justice et procureure généralea donné son consentement à l’établissement des modificationsénoncées ci-dessus.

Heinz J. Luethi662452 NB Ltd O/A Unique Limousine & Car Service34, cour CarsdaleMoncton (N.-B.)E1G 5G2

Commission de l’énergie et des services publicsdu Nouveau-BrunswickBureau 140015, Market SquareC.P. 5001Saint John (N.-B.)E2L 4Y9

Commission des valeursmobilières du Nouveau-Brunswick

Page 36: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1152 Gazette royale — 11 juillet 2012

Summary of AmendmentsNI 21-101 and NI 23-101 (together, the Marketplace Rules) setout the regulatory and reporting requirements applicable to rec-ognized exchanges, recognized quotation and trade reportingsystems and alternative trading systems (ATSs). The Market-place Rules were implemented in December 2001, and theirmain purpose was to establish the regulatory framework withinwhich existing and new marketplaces, such as ATSs, couldoperate.The Amendments give guidance in a number of areas, includingwhat would be considered a marketplace or when indications ofinterest would be considered to be firm orders. One of the keyobjectives of the Amendments is to update and streamline theregulatory and reporting requirements in the Marketplace Rulesand to align, where applicable, the requirements applicable toall marketplaces. They also establish the circumstances underwhich orders are exempt from the pre-trade transparency re-quirements in NI 21-101.

The Amendments update other requirements applicable to mar-ketplaces to address certain issues or situations, such as con-flicts of interest, outsourcing arrangements, or business conti-nuity plans. Lastly, they also extend the current exemption fromtransparency requirements applicable to government debt secu-rities until December 31, 2014 and extend the obligation inNI 23-101 to not intentionally lock or cross markets to market-places in certain circumstances.

Effective DateThe above-noted Amendments come into force in NewBrunswick on July 1st, 2012.

How to Obtain a CopyThe text of the above-noted Amendments can be obtained fromthe Commission’s website: http://www.nbsc-cvmnb.ca.

Paper copies may be obtained from the Commission by writing,telephoning or e-mailing:

SecretaryNew Brunswick Securities Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060Toll Free: 1-866-933-2222 (within N.B. only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]

Résumé des modificationsLa NC 21-101 et la NC 23-101 (ensemble, les règles applicablesaux marchés) prévoient les obligations réglementaires et de dé-pôt applicables aux bourses reconnues, aux systèmes reconnusde cotation et de déclaration d’opérations et aux systèmes de né-gociation parallèle (SNP). Les règles applicables aux marchésont été mises en œuvre en décembre 2001. Leur principal objec-tif était d’encadrer le fonctionnement des marchés existants etdes nouveaux marchés, comme les SNP.Les modifications visent à donner des indications relativementà certains sujets, notamment sur ce qui serait considéré commeun marché ou le moment où les indications d’intérêt seraientconsidérées comme des ordres fermes. Un des objectifs clés desmodifications est de mettre à jour et simplifier les obligationsréglementaires et de dépôt prévues par les règles applicablesaux marchés et harmoniser, s’il y a lieu, les obligations appli-cables à tous les marchés. Elles établissent également les cas oùles ordres sont dispensés des règles de transparence avant lesopérations prévues par la NC 21-101. Les modifications actualisent d’autres obligations applicablesaux marchés pour répondre à certaines questions ou situations,comme les conflits d’intérêts, les ententes d’impartition et lesplans de continuité des activités. Finalement, elles prolongentjusqu’au 31 décembre 2014 la dispense actuelle des règles detransparence applicables aux titres de créance publics et ap-pliquent aux marchés, dans certains cas, l’obligation prévue parla NC 23-101 de ne pas figer ou croiser intentionnellement unmarché.

Date d’entrée en vigueurLes modifications énoncées ci-dessus entrent en vigueur auNouveau-Brunswick le 1er juillet 2012.

Comment obtenir un exemplaireOn trouvera les textes réglementaires des modifications énon-cées ci-dessus par l’entremise du site web de la Commission :http://www.nbsc-cvmnb.ca.

On peut se procurer un exemplaire sur papier des documents encommuniquant par courrier, par téléphone ou par courriel avecla Commission, dont voici les coordonnées :

SecrétaireCommission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au N.-B. seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]

Page 37: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1153 Gazette royale — 11 juillet 2012

TO: JOHN HENRY PHILLIPS, Mortgagor;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.

Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold Property situate at 423 Lansdowne Road, Lansdowne,Carleton County, Province of New Brunswick and known asParcel Identifier Number 10033017.

Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.

The sale is scheduled for Thursday, August 2, 2012, at11:00 a.m., at the Woodstock Court House, 689 Main Street,Woodstock, New Brunswick.See advertisements in the Bugle-Observer in the issues of July3, July 10, July 17 and July 24, 2012.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: ROBERT M. CREAMER, Solicitors for THETORONTO-DOMINION BANK (TD Canada Trust)

________________

TO: JUSTIN ABEL REDIKER AND OLIVIA ELSPETHREDIKER, Mortgagors;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CONCERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold Property situate at 4269 Route 560, Upper Knoxford,Carleton County, Province of New Brunswick and known asParcel Identifier Number 10203131.

Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.

The sale is scheduled for Wednesday, August 2, 2012, at11:15 a.m., at the Woodstock Court House, 689 Main Street,Woodstock, New Brunswick.See advertisements in the Bugle-Observer in the issues of July3, July 10, July 17 and July 24, 2012.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: ROBERT M. CREAMER, Solicitors for THETORONTO-DOMINION BANK (TD Canada Trust)

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, ss.1(2)

To: Troy Robert Spittle and Tasha Marie Spittle, original Mort-gagors; and to all others whom it may concern. Sale pursuant toterms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973,c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property beingsituated at 285 Highway 190, Carlingford, New Brunswick, thesame lot conveyed to Tasha Marie Spittle and Troy RobertSpittle by Transfer registered in the Land Titles Office on No-vember 5, 2007, as document number 24761562.

Notices of Sale

DESTINATAIRES : JOHN HENRY PHILLIPS, débiteurhypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 423, cheminLansdowne, Lansdowne, comté de Carleton, province duNouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification est10033017.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le jeudi 2 août 2012, à 11 h, au palais de jus-tice de Woodstock, 689, rue Main, Woodstock (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions du 3, 10, 17 et24 juillet 2012 du Bugle-Observer.

ROBERT M. CREAMER, du cabinet LAWSON &CREAMER, avocats de LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TD Canada Trust)

________________

DESTINATAIRES : JUSTIN ABEL REDIKER ET OLIVIAELSPETH REDIKER, débiteurs hypothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 4269, route 560,Upper Knoxford, comté de Carleton, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est10203131.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le jeudi 2 août 2012, à 11 h 15, au palais dejustice de Woodstock, 689, rue Main, Woodstock (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions du 3, 10, 17 et24 juillet 2012 du Bugle-Observer.

ROBERT M. CREAMER, du cabinet LAWSON &CREAMER, avocats de LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TD Canada Trust)

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Troy Robert Spittle et Tasha Marie Spittle, débi-teurs hypothécaires originaires; et tout autre intéressé éventuel.Vente effectuée conformément aux dispositions de l’acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19. Biens en tenure libre situés au 285, route 190,Carlingford (Nouveau-Brunswick), et correspondant au mêmelot ayant été transféré à Tasha Marie Spittle et à Troy RobertSpittle par l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregis-trement foncier le 5 novembre 2007 sous le numéro 24761562.

Avis de vente

Page 38: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1154 Gazette royale — 11 juillet 2012

Notice of Sale given by The Bank of Nova Scotia as Mortgagee.Sale to be held at the former Victoria County Court House lo-cated at 1135 West Riverside Drive, Perth-Andover, NewBrunswick, on the 24th day of July, 2012, at the hour of11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of MortgageSale in The Victoria Star dated June 27, July 4, July 11 and July18, 2012.

McInnes Cooper, Solicitors for The Bank of Nova Scotia, Per:T. Ryan Seymour, Barker House, Suite 600, 570 Queen Street,P.O. Box 610, Station A, Fredericton, New Brunswick,E3B 5A6, Telephone: 506-458-8572, Facsimile: 506-458-9903

________________

To: Travacom Properties Inc., of 1789 Route 124, Springfield,in the Province of New Brunswick, Mortgagor;And to: All Others Whom it May Concern.Freehold property situate, lying and being at Bayside, in theCounty of Charlotte and Province of New Brunswick, PIDNumber 15084130, 15178635, 1235613 and 15181647.Notice of Sale given by Angela Faye Day and Joseph RomualdHoule, Mortgagees, holders of the first mortgage.

Sale on the 22nd day of August, 2012, at 11:00 a.m., at the TownHall in St. Stephen, 73 Milltown Boulevard, St. Stephen, NewBrunswick. See advertisement in The Saint Croix Courier.

MacDonald Ames, Solicitors for the Mortgagees, Angela FayeDay and Joseph Romuald Houle

________________

To: Mary Darlene Sears, of Tide Head, in the County ofRestigouche and Province of New Brunswick and John PatrickSears, of the City of Campbellton, in the County of Restigoucheand Province of New Brunswick, Mortgagors;And to: All others whom it may concern.Freehold premises situate, lying and being at 326 RestigoucheDrive, Tide Head, in the County of Restigouche and Province ofNew Brunswick.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 17th day of August, 2012, at 11:00 a.m., at the CourtHouse in Campbellton, 157 Water Street, Campbellton, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement in TheTribune.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

________________

TO: KEVIN HOWARD KINNEY and ELIANNE MAYKINNEY, of 140 Bunker Street, Fredericton, in the County ofYork and Province of New Brunswick, Mortgagor;

AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.

Avis de vente donné par la Banque de Nouvelle-Écosse, créan-cière hypothécaire. La vente aura lieu le 24 juillet 2012, à 11 h,heure locale, à l’ancien palais de justice du comté de Victoria si-tué au 1135, promenade West Riverside, Perth-Andover(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdu 27 juin et des 4, 11 et 18 juillet 2012 du journal The VictoriaStar.

T. Ryan Seymour, du cabinet McInnes Cooper, avocats dela Banque de Nouvelle-Écosse, Barker House, bureau 600,570, rue Queen, C.P. 610, succursale A, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A6; téléphone : 506-458-8572; télécopieur :506-458-9903

________________

Destinataires : Travacom Properties Inc., du 1789, route 124,Springfield (Nouveau-Brunswick), débiteur hypothécaire;Et tout autre intéressé éventuel.Biens en tenure libre situés à Bayside, comté de Charlotte, pro-vince du Nouveau-Brunswick, et dont les NID sont 15084130,15178635, 1235613 et 15181647.Avis de vente donné par Angela Faye Day et Joseph RomualdHoule, créanciers hypothécaires et titulaires de la première hy-pothèque.La vente aura lieu le 22 août 2012, à 11 h, à l’hôtel de ville deSt. Stephen, 73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans le journal The SaintCroix Courier.

MacDonald Ames, avocats des créanciers hypothécaires,Angela Faye Day et Joseph Romuald Houle

________________

Destinataires : Mary Darlene Sears, de Tide Head, comté deRestigouche, province du Nouveau-Brunswick, et John PatrickSears, de la ville de Campbellton, comté de Restigouche, pro-vince du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;Et tout autre intéressé éventuel.Lieux en tenure libre situés au 326, promenade Restigouche,Tide Head, comté de Restigouche, province du Nouveau-Brunswick.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 17 août 2012, à 11 h, au palais de justicede Campbellton, 157, rue Water, Campbellton (Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve le droit dereporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annonce publiéedans le journal The Tribune.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

________________

DESTINATAIRES : KEVIN HOWARD KINNEY etELIANNE MAY KINNEY, du 140, rue Bunker, Fredericton,comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hy-pothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Page 39: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1155 Gazette royale — 11 juillet 2012

Freehold premises known as PID 75419564, situate, lying andbeing at 140 Bunker Street, Fredericton, in the County of Yorkand Province of New Brunswick.Notice of Sale given by the Toronto-Dominion Bank, holder ofthe first mortgage.Sale on the 1st day of August, 2012, at 11:00 a.m., at theFredericton Court House, 427 Queen Street, in the City ofFredericton, in the County of York, New Brunswick.See advertisement in The Daily Gleaner.Sale conducted under the terms of the mortgage and the Prop-erty Act, R.S.N.B., 1973, Chapter P-19, as amended.

DATED at the City of Moncton, in the County of Westmorlandand Province of New Brunswick, this 22nd day of June, 2012.

WILBUR & WILBUR, Solicitors for the Mortgagee, TheToronto-Dominion Bank

________________

TO: CHARLOTTE REALTY (1997) LTD., of 140 MilltownBoulevard, St. Stephen, New Brunswick, E3L 1G6, Mortgagor;

AND TO: ROYAL BANK OF CANADA, 26 Milltown Bou-levard, St. Stephen, New Brunswick, E3L 1G3, Mortgagee;

AND TO: ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being at 140 MilltownBoulevard, St. Stephen, New Brunswick, in the Parish ofSt. Stephen, County of Charlotte, and Province of NewBrunswick, also known as PIDs 1252774 and 1306075.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 27th day of August, 2012, at 10:30 a.m., at theCharlotte County Registry Office in St. Stephen, 73 MilltownBoulevard, St. Stephen, New Brunswick. The Mortgagee re-serves the right to postpone or reschedule the time and date ofsale. See advertisement in The Saint Croix Courier.

George L. Cooper of Cox & Palmer, Solicitors for the Mort-gagee, the Royal Bank of Canada

________________

To: Danny Delange and Louise Thibodeau, of Saint-Quentin, inthe County of Madawaska and Province of New Brunswick,Mortgagor;And to: Bank of Montreal, c/o McInnes Cooper, 644 MainStreet, P.O. Box 1386, Moncton, NB, E1C 8T8, JudgementCreditor;And to: New Brunswick Legal Aid Services Commission,19 Aberdeen Street, Suite 201, Campbellton, NB, E3N 2J6,Lien Claimant;And to: Royal Bank of Canada, c/o Cox & Palmer, 644 MainStreet, Moncton, NB, E1C 1E2, Judgment Creditor;

And to: All others whom it may concern.

Lieux en tenure libre situés au 140, rue Bunker, Fredericton,comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont leNID est 75419564.Avis de vente donné par La Banque Toronto-Dominion, titu-laire de la première hypothèque.La vente aura lieu le 1er août 2012, à 11 h, au palais de justicede Fredericton, 427, rue Queen, ville de Fredericton, comté deYork, province du Nouveau-Brunswick.Voir l’annonce publiée dans le journal The Daily Gleaner.Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-thèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B., 1973,chapitre P-19.FAIT dans la ville de Moncton, comté de Westmorland, pro-vince du Nouveau-Brunswick, le 22 juin 2012.

WILBUR & WILBUR, avocats de la créancière hypothécaire,La Banque Toronto-Dominion

________________

DESTINATAIRES : CHARLOTTE REALTY (1997)LTD., du 140, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick) E3L 1G6, débiteur hypothécaire;BANQUE ROYALE DU CANADA, 26, boulevard Milltown,St. Stephen (Nouveau-Brunswick) E3L 1G3, créancière hypo-thécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 140, boulevard Milltown,St. Stephen, paroisse de St. Stephen, comté de charlotte, pro-vince du Nouveau-Brunswick, et dont les NID sont 1252774 et1306075.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 27 août 2012, à 10 h 30, au bureau de l’en-registrement du comté de Charlotte de St. Stephen, situé au73, boulevard Milltown, St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Lacréancière hypothécaire se réserve le droit de reporter la date etl’heure de la vente. Voir l’annonce publiée dans le journal TheSaint Croix Courier.

George L. Cooper, du cabinet Cox & Palmer, avocats de lacréancière hypothécaire, la Banque Royale du Canada

________________

Destinataires : Danny Delange et Louise Thibodeau, de Saint-Quentin, comté de Madawaska, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires;Banque de Montréal, a/s de McInnes Cooper, 644, rue Main,C.P. 1386, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T8, créan-cière sur jugement;Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, 19, rue Aberdeen, bureau 201, Campbellton(Nouveau-Brunswick) E3N 2J6, demanderesse de privilège;Banque Royale du Canada, a/s de Cox & Palmer, 644, rue Main,Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1E2, créancière sur juge-ment;Et tout autre intéressé éventuel.

Page 40: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1156 Gazette royale — 11 juillet 2012

Freehold premises situate, lying and being at 36 Mgr MartinOuest Road, Saint-Quentin, in the County of Madawaska andProvince of New Brunswick, PID 50209931.Notice of Sale given by the Royal Bank of Canada, holder of thefirst mortgage.Sale on the 22nd day of August, 2012, at the hour of 11:00o’clock in the forenoon, at the Court House at the City ofEdmundston, at 121 Church Street, Edmundston, NewBrunswick. The Mortgagee reserves the right to postpone or re-schedule the time and date of sale. See advertisement in theLe Madawaska.

Cox & Palmer, Solicitors for the Mortgagee, the Royal Bank ofCanada

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’sPrinter Office, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separatefrom the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Queen’s Printermay refuse to publish a document if any part of it is illegible,and may delay publication of any document for administrativereasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice to Advertisers

Lieux en tenure libre situés au 36, chemin Mgr-Martin Ouest,Saint-Quentin, comté de Madawaska, province du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 50209931.Avis de vente donné par la Banque Royale du Canada, titulairede la première hypothèque.La vente aura lieu le 22 août 2012, à 11 h, au palais de justicede la ville d’Edmundston, 121, rue de l’Église, Edmundston(Nouveau-Brunswick). La créancière hypothécaire se réserve ledroit de reporter la date et l’heure de la vente. Voir l’annoncepubliée dans Le Madawaska.

Cox & Palmer, avocats de la créancière hypothécaire, la BanqueRoyale du Canada

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, aumoins sept jours avant le mercredi de publication. Chaqueavis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signa-taires doivent suivre immédiatement la signature. L’Impri-meur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une par-tie est illisible et retarder la publication d’un avis pour desraisons administratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété(Formule 70B)

Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 posur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis aux annonceurs

Page 41: The Royal Gazette / Gazette royale (12/07/11) · The Royal Gazette — July 11, 2012 1119 Gazette royale — 11 juillet 2012 3. Under subparagraph 11(1)(d)(iii)) of the Economic and

The Royal Gazette — July 11, 2012 1157 Gazette royale — 11 juillet 2012

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney general/royal gazette.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 13%tax, plus shipping and handling where applicable.

Office of the Queen’s Printer670 King Street, Room 117

P.O. Box 6000Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520 Fax: 506-457-7899E-mail: [email protected]

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établià l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur general/gazette royale.html

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la sommede 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 13 %, ainsi que les fraisapplicables de port et de manutention.

Bureau de l’Imprimeur de la Reine670, rue King, pièce 117

C.P. 6000Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1Tél. : 506-453-2520 Téléc. : 506-457-7899

Courriel : [email protected]

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés


Recommended