+ All Categories
Home > Documents > The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale...

The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale...

Date post: 02-Apr-2018
Category:
Upload: dothuy
View: 221 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
34
The Royal Gazette Fredericton New Brunswick Gazette royale Fredericton Nouveau-Brunswick Vol. 173 Wednesday, April 15, 2015 / Le mercredi 15 avril 2015 401 ISSN 1714-9428 Notice to Readers The Royal Gazette is officially published on-line. Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted. Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least seven working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator at 453-8372. PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-61, I declare that the Oppor- tunities New Brunswick Act, Chapter 2 of the Acts of New Brunswick, 2015, with the exception of subsections 35(2), (4), (6) and (8) to (11), paragraph 35(12)(b) and subsection 35(13), comes into force on April 1, 2015. This Proclamation is given under my hand and the Great Seal of the Province at Fredericton on March 27, 2015. Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy-Vienneau Attorney General Lieutenant-Governor ________________ Proclamations Avis aux lecteurs La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne. Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis. Les documents à publier doivent parvenir à la coordon- natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale au 453-8372. PROCLAMATION Conformément au décret en conseil 2015-61, je déclare le 1 er avril 2015 date d’entrée en vigueur de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, à l’exception des paragraphes 35(2), (4), (6) et (8) à (11), de l’alinéa 35(12)b) et du paragraphe 35(13). La présente proclamation est faite sous mon seing et sous le grand sceau de la province, à Fredericton, le 27 mars 2015. Le procureur général, La lieutenante-gouverneure, Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy Vienneau ________________ Proclamations
Transcript
Page 1: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The RoyalGazette

FrederictonNew Brunswick

Gazetteroyale

FrederictonNouveau-Brunswick

Vol. 173 Wednesday, April 15, 2015 / Le mercredi 15 avril 2015 401

ISSN 1714-9428

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.

Except for formatting, documents are published in TheRoyal Gazette as submitted.

Material submitted for publication must be received bythe Royal Gazette Coordinator no later than noon, at leastseven working days prior to Wednesday’s publication.However, when there is a public holiday, please contactthe Royal Gazette Coordinator at 453-8372.

PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2015-61, I declare that the Oppor-tunities New Brunswick Act, Chapter 2 of the Acts of NewBrunswick, 2015, with the exception of subsections 35(2), (4),(6) and (8) to (11), paragraph 35(12)(b) and subsection 35(13),comes into force on April 1, 2015.

This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on March27, 2015.

Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy-VienneauAttorney General Lieutenant-Governor

________________

Proclamations

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dansla Gazette royale tels que soumis.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordon-natrice de la Gazette royale, à midi, au moins sept joursouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jourférié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de laGazette royale au 453-8372.

PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2015-61, je déclare le1er avril 2015 date d’entrée en vigueur de la Loi constituantOpportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois duNouveau-Brunswick de 2015, à l’exception des paragraphes35(2), (4), (6) et (8) à (11), de l’alinéa 35(12)b) et du paragraphe35(13).

La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 27 mars 2015.

Le procureur général, La lieutenante-gouverneure,Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy Vienneau

________________

Proclamations

Page 2: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015

PROCLAMATIONPursuant to Order in Council 2015-37, I declare that An Act toAmend the Fish and Wildlife Act, Chapter 23 of the Acts of NewBrunswick, 2014, comes into force on March 30, 2015.

This Proclamation is given undermy hand and the Great Seal of theProvince at Fredericton on March11, 2015.

Serge Rousselle, Q.C. Jocelyne Roy-VienneauAttorney General Lieutenant-Governor

FEBRUARY 26, 20152015-29

1. Under paragraph 31(1)(d) of the Control of MunicipalitiesAct, the Lieutenant-Governor in Council orders that the Villagede St. Hilaire is subject to the provisions of Part V of the Controlof Municipalities Act.2. Under subsection 33(1) of the Control of Municipalities Act,the Lieutenant-Governor in Council appoints Rino Pelletier asthe supervisor of the Village de St. Hilaire and vests in the su-pervisor all those powers conferred upon a supervisor pursuantto Part V of the Control of Municipalities Act.

J. Ernest Drapeau, Administrator

________________

FEBRUARY 26, 20152015-31

Under section 6 of the Economic Development Act, theLieutenant-Governor in Council appoints the following personsas members of the New Brunswick Industrial DevelopmentBoard, for a term to expire February 16, 2017:

(a) Stephen Lund, designated as Chairperson; and(b) Denis Caron, designated as Vice-Chairperson.

J. Ernest Drapeau, Administrator

________________

MARCH 18, 20152015-43

Under subsections 8(1), 8(2) and 9(1) of the Combat Sport Act,the Lieutenant-Governor in Council appoints Isabelle-AnneGirouard, a medical practitioner, Shediac, New Brunswick, as amember of the New Brunswick Combat Sport Commission, fora term of three years, effective March 18, 2015.

Jocelyne Roy Vienneau, Lieutenant-Governor

Orders in Council

PROCLAMATIONConformément au décret en conseil 2015-37, je déclare le30 mars 2015 date d’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loisur la pêche sportive et la chasse, chapitre 23 des Lois duNouveau-Brunswick de 2014.

La présente proclamation est faitesous mon seing et sous le grandsceau de la province, à Fredericton,le 11 mars 2015.

Le procureur général, La lieutenante-gouverneure,Serge Rousselle, c.r. Jocelyne Roy Vienneau

LE 26 FÉVRIER 20152015-29

1. En vertu de l’alinéa 31(1)d) de la Loi sur le contrôle des mu-nicipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne que leVillage de Saint-Hilaire tombe sous le coup des dispositions dela partie V de la Loi sur le contrôle des municipalités.2. En vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le contrôle desmunicipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme RinoPelletier administrateur du Village de Saint-Hilaire pour qu’ilexerce les pouvoirs conférés à un administrateur conformémentà la partie V de la Loi sur le contrôle des municipalités.

L’administrateur, J. Ernest Drapeau

________________

LE 26 FÉVRIER 20152015-31

En vertu de l’article 6 de la Loi sur le développement écono-mique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les per-sonnes suivantes membres du Conseil de développement indus-triel du Nouveau-Brunswick, pour un mandat prenant fin le16 février 2017 :

a) Stephen Lund, qui est désigné président; etb) Denis Caron, qui est désigné vice-président.

L’administrateur, J. Ernest Drapeau

________________

LE 18 MARS 20152015-43

En vertu des paragraphes 8(1), 8(2) et 9(1) de la Loi sur lessports de combat, le lieutenant-gouverneur en conseil nommeIsabelle-Anne Girouard, médecin, de Shediac (Nouveau-Brunswick), membre de la Commission des sports de combat duNouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du18 mars 2015.

La lieutenante-gouverneure, Jocelyne Roy Vienneau

Décrets en conseil

Page 3: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 403 Gazette royale — 15 avril 2015

19 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF MONCTON CENTRE (District No. 19) / ASSOCIATIONPROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE MONCTON-CENTRE (Circonscription no 19)

Official Agent / Agente officielle Natasha Ostaff220, promenade Shannon DriveMoncton, NB E1G 2G2

27 PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION OF HAMPTON (District No. 27) / ASSOCIATIONPROGRESSISTE-CONSERVATRICE DE HAMPTON (Circonscription no 27)

Official Agent / Agent officiel Peter Behr218, chemin Kennebecasis River RoadHampton, NB E5N 6K9

16 MEMRAMCOOK-TANTRAMAR NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 16) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MEMRAMCOOK-TANTRAMAR(Circonscription no 16)

President / Président Norbert LeBlanc20, rue Hilarion StreetMemramcook, NB E4K 2M7

1st Vice-President / 1re Vice-présidente Beth Barczyk12, avenue Brooks AvenueSackville, NB E4L 3R2

2nd Vice-President / 2e Vice-présidente Fay Morrissey18, promenade Hestler DriveSackville, NB E4L 3E2

3rd Vice-President / 3e Vice-présidente Julie Vautour830, chemin Royal RoadMemramcook, NB E4K 3E1

Secretary / Secrétaire Pam Dupuis600, rue Centrale StreetMemramcook, NB E4K 0B3

Treasurer / Trésorière Dorothy Thériault452, route La Vallée RouteMemramcook, NB E4K 2A3

Official Representative / Représentante officielle Dorothy Thériault452, route La Vallée RouteMemramcook, NB E4K 2A3

Conformément à l’article 149 de la Loi électorale, chapitre E-3,province du Nouveau-Brunswick, les changements suivants auxenregistrements originaux ont été inscrits au registre des partispolitiques entre le 1er février 2015 et le 31 mars 2015 :

ÉlectionsNouveau-Brunswick

Pursuant to section 149 of the Elections Act, chapter E-3, Prov-ince of New Brunswick, the following changes to the originalregistrations have been entered in the Registry of Political Par-ties between February 1st, 2015 and March 31st, 2015:

ElectionsNew Brunswick

Page 4: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 404 Gazette royale — 15 avril 2015

02 CAMPBELLTON-DALHOUSIE NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 02) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CAMPBELLTON-DALHOUSIE (Cir-conscription no 02)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

03 RESTIGOUCHE-CHALEUR NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 03) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE RESTIGOUCHE-CHALEUR (Circonscrip-tion no 03)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

08 TRACADIE-SHEILA NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 08) / ASSOCIATION DE CIR-CONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE TRACADIE-SHEILA (Circonscription no 08)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

14 SHEDIAC BAY-DIEPPE NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 14) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE BAIE DE SHEDIAC-DIEPPE (Circonscrip-tion no 14)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

15 SHEDIAC-BEAUBASSIN-CAP-PELÉ NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 15) / ASSOCI-ATION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE SHEDIAC-BEAUBASSIN-CAP-PELÉ (Circonscription no 15)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

16 MEMRAMCOOK-TANTRAMAR NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 16) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MEMRAMCOOK-TANTRAMAR(Circonscription no 16)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

17 DIEPPE NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 17) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIP-TION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE DIEPPE (Circonscription no 17)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

Page 5: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 405 Gazette royale — 15 avril 2015

18 MONCTON EAST NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 18) / ASSOCIATION DE CIRCON-SCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MONCTON-EST (Circonscription no 18)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

20 MONCTON SOUTH NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 20) / ASSOCIATION DE CIR-CONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE MONCTON-SUD (Circonscription no 20)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

27 HAMPTON NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 27) / ASSOCIATION DE CIRCONSCRIP-TION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE HAMPTON (Circonscription no 27)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

36 CHARLOTTE-CAMPOBELLO NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 36) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE CHARLOTTE-CAMPOBELLO (Cir-conscription no 36)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

37 OROMOCTO-LINCOLN NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 37) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE D’OROMOCTO-LINCOLN (Circonscriptionno 37)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

39 NEW MARYLAND-SUNBURY NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 39) / ASSOCIATIONDE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE NEW MARYLAND-SUNBURY (Circon-scription no 39)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

40 FREDERICTON SOUTH NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 40) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-SUD (Circonscriptionno 40)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

Page 6: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 406 Gazette royale — 15 avril 2015

41 FREDERICTON NORTH NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 41) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-NORD (Circonscriptionno 41)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

42 FREDERICTON-YORK NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 42) / ASSOCIATION DECIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-YORK (Circonscriptionno 42)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

43 FREDERICTON WEST-HANWELL NEW DEMOCRATIC PARTY ASSOCIATION (District No. 43) / ASSOCIA-TION DE CIRCONSCRIPTION DU NOUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE DE FREDERICTON-OUEST-HANWELL (Circonscription no 43)

Official Representative / Représentant officiel Stephen Yardy2-924, rue Prospect StreetFredericton, NB E3B 2T9

PEOPLE’S ALLIANCE OF NEW BRUNSWICK / L’ALLIANCE DES GENS DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Leader / Chef Kris Austin601, promenade Northside DriveMinto, NB E4B 3B6

President / Présidente Joan Seeley46, chemin Duffy RoadBlack River, NB E2S 2A4

1st Vice-President / 1er Vice-président Carl Bainbridge86, promenade Lonsdale DriveMoncton, NB E1G 2H9

Secretary / Secrétaire Randall Leavitt363, rue MacPherson StreetFredericton, NB E3A 5H2

Treasurer / Trésorière Patricia Wilkins204, promenade Manresa DriveFredericton, NB E3A 5W2

Official Representative / Représentant officiel Kris Austin601, promenade Northside DriveMinto, NB E4B 3B6

Page 7: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 407 Gazette royale — 15 avril 2015

512661 512661 N.B. LTEE515130 515130 N.B. LTD.602354 602354 N. B. LTD.602498 602498 NB Inc.602629 602629 N.B. INC.602659 602659 N.B. Inc.613988 613988 N.B. Inc.620836 620836 NB LTD.633587 633587 NB INC.639752 639752 N.B. Inc.639910 639910 N.B. Inc.639933 639933 N.B. Inc.639959 639959 N.B. Inc.646077 646077 N.B. Limited646098 646098 N.B. LTD.646193 646193 N.B. LTD.646370 646370 NB Ltd.646391 646391 N.B. LTD.646469 646469 NB Inc.652664 652664 NB Inc.652691 652691 N.B. Inc.652789 652789 N.B. Inc.652861 652861 NB Inc.659114 659114 N.B. LTD.659277 659277 NB INC.665207 665207 N.-B. Inc.- 665207 NB Inc.665293 665293 N.B. Ltd.665324 665324 N.B. Inc.665328 665328 NB Ltd.665535 665535 NB Ltd.665545 665545 NEW BRUNSWICK

CORPORATION665552 665552 N.B. INC.665579 665579 N.B. Inc.665645 665645 N.B. Ltd.665675 665675 N.B. Ltd.659340 A W Nicholson Ltd.652689 A.P.I. Atlantic Preventive Inspections Inc.512638 Adair’s Lodge and Cabins Inc.627175 All About Animals Inc665612 All Trades Construction and Renovations

Ltd.627309 Allroad Projects Limited652813 ANSTIS GROUP INC.658977 Artiman Trading Inc.665351 Atlantic Duct Cleaning Nettoyage de

tuyaux atlantique Ltee665390 B & M Online Ltd.627133 B.C.E. Transport Inc.665666 Back to Nature Camping NB Ltd.639805 Berjaya Synergy Inc.658953 BFH RÉNOVATION LTÉE

054886 BLACKS HARBOUR SUPERMARKET LTD.

620615 Boulier Home Care Services Inc.614138 BOUTIQUE ANISE INC.608163 Buchanan Group Inc.665513 Capital City Builders Inc.665560 CardioAction Sports Ware Inc.665522 Careers In Code Inc.058097 CARREG HOLDINGS LIMITED665489 Casa de las Americas Coffee Shop Inc.665264 Century Siding & Roofing Inc.633265 CHALEUR REALTY

DEVELOPMENTS INC.658986 CHIURAZZI INTERNATIONAL LTD.665462 Chronos Heritage & Archaeological

Consulting Inc.665649 CLCR Holdings Limited507559 Click Communications Inc.633299 Craig P. Silliker Professional Corporation006481 DAVID C. FRANCIS CO. LTD.005033 DINO’S PIZZA RESTAURANTS LTD.037986 DONLEEN HOLDINGS LTD.665370 Dr. Akinloye Professional Corporation620691 Dr. N. Sharma Professional Corporation659045 DRB MARINE AND TECHNICAL

SURVEY LTD.058306 EASTSIDE WELDING 1994 LTD.652473 Electrify Electrics Inc.608068 ENTERTAINMENT PUBLICATIONS

OF CANADA, LIMITED LES PUBLICATIONS DE DIVERTISSEMENTS DU CANADA, LIMITEE

652754 Evolve Energy Concepts Inc.607990 FOOTSPUR INC.665219 FOREN STAR BASE CODING INC.665300 Frontier Technical Services Inc.602808 Fruits de mer St-Thomas Seafood Limitée058228 GABRIEL ELECTRIC LTD.502932 GESTION G. ALLAIN MANAGEMENT

INC.620608 Global Plastics Services International Inc.652844 GREENSTAR RECYCLING LTD.640051 Heston Canada Ltd.665652 Intimate Desires by Crystal Ltd.665654 J&P Trucking Services Inc.500730 JACQUOT PIECES D’AUTO INC.500662 JADE VENTURES LTD.614299 JAMES TOWING INC.659232 Landdrill Contract Mining Ltd.665618 Last Leak Roofing & Ventilation Inc.665297 LIRO Natural Resources Ltd.

665184 Loyalist City Pawn Shop Inc.665599 M & M CHARLTON HOLDINGS LTD.652418 Macprofessionals Canada, Inc.052446 MANDATE ERECTORS & WELDING

LTD.602805 MARITIME MEDICAL HOLDINGS

CORPORATION602417 MARK K. BELLIVEAU

CORPORATION PROFESSIONNELLE INC.

011005 MING GARDEN LTD.640106 Miramichi Early Learning & Care Inc.659249 Mr. Go Restaurant Ltd.620481 NEGO CORP. LTD.627251 NEXT LEVEL CONSULTING GROUP

INC.627393 NICHE PRODUCTS LIMITED652805 NWA Canada Corp.048013 OBJETS D’ART PASSE-PARTOUT INC.602505 OLD TOWN CONSTRUCTION LTD.639934 OZONE HOCKEY INC.665619 PHARMACIE BOUDREAU

FITZPATRICK LTÉE665516 Pools Plus Amusements Inc.608091 Precision Fabricating Equipment Inc.633674 QUALITY GAS SERVICES INC.045519 R Y G CORMIER ELECTRIC LTD./

LTEE.659172 Redline Roofing Inc.500648 REPTILE OCEAN INC.665672 RobertNormand Actor Inc.620503 S.L. Lewis Fuels Inc.665534 Shawarma Hut Inc.665266 SPARIVAR INC.620758 Stevens & Associates Land Use Planning

Ltd.512641 STSN Canada Limited620501 Sunflower Atlantic Recycling Ltd.515027 SUPER DECKER INC.665598 THE DAUGHTERS FINE DINING LTD.626924 The Hardwood Brick Company Inc.652611 Tillmann Electronics Ltd.620519 Trinity Enterprise Inc.665520 TRIPLE H. KITCHENS & BATHS LTD.652842 VAN COR PROPERTY

MANAGEMENT INC.512708 VAUGHAN PROPERTIES INC.659210 WA FOREIGN EXCHANGE LIMITED659245 YUXINLONG INTERNATIONAL

LIMITED

Avis de dissolution de corporations provinciales et d’annulationde l’enregistrement des corporations extraprovinciales

Avis de dissolution de corporations provincialesSachez que les corporations provinciales suivantes ont été dissoutes endate du 27 mars 2015 en vertu de l’alinéa 139(1)c) de la Loi sur lescorporations commerciales, puisque lesdites corporations ont fait dé-faut de faire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents re-quis par la Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du27 mars 2015.

Loi sur les corporationscommerciales

Notice of dissolution of provincial corporations and cancella-tion of the registration of extra-provincial corporations

Notice of dissolution of provincial corporationsTake notice that the following provincial corporations have been dis-solved as of March 27, 2015, pursuant to paragraph 139(1)(c) of theBusiness Corporations Act, as the said corporations have been indefault in sending to the Director fees, notices and/or documents re-quired by the Act. Certificates of Dissolution have been issued datedMarch 27, 2015.

Business Corporations Act

_____________________________________________________

Page 8: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 408 Gazette royale — 15 avril 2015

652662 2224408 Ontario Inc.602809 4093879 CANADA LTD.602810 4093887 CANADA LTD.665432 AAXEL INSURANCE BROKERS LTD.665377 Any Time Money Limited640057 AUBIE GROUP HOLDINGS LTD.

665610 Dawn-Works Inc.665310 EMPLOYERS FIRST INC.620516 Extermination Acadia Pest Control (1988)

Inc.076851 H.R. Associates Inc.646237 Optimal Water Solutions Inc.

077827 PENSON FINANCIAL SERVICES CANADA INC.

639832 Pétrolia Inc.659017 Savoie & Boudreau Inc.659153 VICKAR COMMUNITY CHEVROLET

LTD.

652776 Association étudiante de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires Inc.

640086 CAMBRIDGE NARROWS EARLY LEARNING AND CHILDCARE CENTRE INC.

003292 CENTRE D’ARTISANAT REGIONAL DE BERTRAND INC.

024805 CENTRE INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INFOROUTE EN FRANCAIS (CIDIF) INC.

652503 CHINESE STUDENTS AND SCHOLARS ASSOCIATION INC.

022550 FAMILY MEDIATION NEW BRUNSWICK/MEDIATIONS FAMILIALE NOUVEAU BRUNSWICK INC.

633686 FEEDING PERFORMANCE INC.021939 FUNDY ARENA INC.024058 KACHI INC.025644 Le Regroupement des Producteurs de

Bleuets de la Grande Rivière Tracadie Inc.

602393 Moncton-Sable Inc.014330 R. C. S. - NETHERWOOD ALUMNI

INC.665376 Sustainable Saint John Inc.659252 SYC - SUSSEX YOUTH CENTER Inc.665549 Wabanaki Teaching Lodge Incorporated

Notice of cancellationof registration of extra-provincial corporations

Take notice that the registrations of the following extra-provincial cor-porations have been cancelled as of March 27, 2015, pursuant to para-graph 201(1)(a) of the Business Corporations Act as the said corpora-tions have been in default in sending to the Director fees, notices and/or documents required by the Act:

Avis d’annulation del’enregistrement des corporations extraprovinciales

Sachez que l’enregistrement des corporations extraprovinciales sui-vantes a été annulé en date du 27 mars 2015 en vertu de l’alinéa201(1)a) de la Loi sur les corporations commerciales, puisque lesditescorporations ont fait défaut de faire parvenir au Directeur les droits,avis et/ou documents requis par la Loi :

Avis de dissolution de compagnies provincialesSoyez avisé que les compagnies provinciales suivantes ont été dis-soutes en date du 27 mars 2015 en vertu de l’alinéa 35(1)c) de la Loisur les compagnies, puisque lesdites compagnies ont fait défaut defaire parvenir au Directeur les droits, avis et/ou documents requis parla Loi. Les certificats de dissolution délivrés sont datés du 27 mars2015.

Loi sur les compagnies

Notice of dissolution of provincial companiesTake notice that the following provincial companies have been dis-solved as of March 27, 2015, pursuant to paragraph 35(1)(c) of theCompanies Act, as the said companies have been in default in sendingto the Director fees, notices and/or documents required by the Act. Cer-tificates of Dissolution have been issued dated March 27, 2015.

Companies Act

SACHEZ QUE, conformément aux articles 12.3 et 12.31 de la Loi surl’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellationscommerciales, L.R.N.-B. de 1973, chap. P-5, le registraire a annulé, le27 mars 2015, en vertu de ladite loi, l’enregistrement des certificats desociétés en nom collectif indiqués à l’Annexe « A » ci-jointe et des cer-tificats d’appellations commerciales des commerces indiqués à l’an-nexe « B » ci-jointe en raison du fait que ces firmes ou commerces ontnégligé de faire enregistrer des certificats de renouvellement confor-mément à l’alinéa 3(1)b) ou c) ou au paragraphe 3.1(2) ou 9(7) de laditeloi, selon le cas.

Loi sur l’enregistrement dessociétés en nom collectif et

des appellations commerciales

TAKE NOTICE that, pursuant to sections 12.3 and 12.31 of the Part-nerships and Business Names Registration Act R.S.N.B., 1973, c. P-5,the Registrar under the said Act has cancelled, effective March 27,2015, the registration of the certificates of partnership of the firms setforth in Schedule “A” annexed hereto and the certificates of businessnames of the businesses set forth in Schedule “B” annexed hereto byreason of the fact the said firms and businesses have failed to registercertificates of renewal in accordance with paragraph 3(1)(b) or (c) orsubsection 3.1(2) or 9(7), as the case may be applicable, of the said Act.

Partnerships and BusinessNames Registration Act

Page 9: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 409 Gazette royale — 15 avril 2015

645260 A & S Healthy Chocolate645754 Abounding Grace Bed And Breakfast645267 Centre d’Entraide Jeunesse645337 CSM Counter Tops644205 Dawgy Stylz

644429 Eight Second Records645190 Galerie d’Art 46e Parallèle/ 46th Parallel

Art gallery607385 M.A.G. & FRERES (2003)645169 McLarin Real Estate

644994 Naturally Fit Edmundston645187 Odessa Enterprises607165 SMOKEY MOUNTAIN SPECIALTY

FOODS644750 The Inukshuk Center

645428 “A” O.K. ELECTRIC645205 3J LAROCQUE ENR.645550 Adams Custom Cabinets645284 ads2go645436 All Business Realty645059 Anything For YOU645455 APOLLO NEWS645345 Assurance Solidia Insurance645438 Atlantic Basement Waterproofing607536 Atlantic Rain Flo Systems645423 Atlantic Wetland Solutions645239 ATLANTIC WINDOW WASHERS645425 ATLANTICA LIVE645427 ATLANTICA LIVE RECORDS645426 ATLANTICA STUDIOS645231 Attitude Aesthetics645356 Au Pti Tresors d’Acadie645215 Augi’s Auto Detailing645505 AutoSwag motorsport & performance645218 B & M Painting645129 B&K BEANS TO BREW645355 Bags of Pursesonality336717 Bartels Hardwood Flooring645563 Bella Bohème, Bella Coiffure645544 Best Cleaners645476 BiMa Metti Hair Studio645682 Bircholme Holdings644192 Bistro Nutrio To Go347236 BLOCKBUSTER CANADA347233 BLOCKBUSTER VIDEO CANADA347235 BLOCKBUSTER VIDEO CANADA/

VIDEO BLOCKBUSTER CANADA645224 Blossom Cleaning644992 Bourgoin Hard Wood Floors & Ceramic

Tile607835 BRENT’S TRUCK STOP644920 Busy Boys Handyman Services645173 Cal Nutrasciences Canada645560 CANAVANS FC APPRAISALS645116 Celiro Pet Supply645141 CHEER-TASTIC STYLE645140 Chef’s Restaurant645025 Cheryl’s Hearing Services607858 Chipman Tire & Auto Services645551 Clinique pied sur terre329012 COLDWELL BANKER - FIRST

CHOICE REALTY645570 Consultant S.E.M. Consultant Enrg.607090 Craig’s Painting & Decorating645175 Creativia Concepts645182 Crystal Clear Concepts645227 Custom Classics & Cycle Works645222 Cute Nails & Esthetics645351 Dale’s Small Engine645486 DALLON ENTERPRISES645484 Domethilde Enterprise645014 Eager Beaver Contracting644982 EAST COAST ASPHALT

MAINTENANCE645283 Easter Seals New Brunswick645415 Edge Health & Fitness619465 Edwards

645028 ENTER GODDESS LIFE STYLING645085 Essential Health Equine Apothecary329049 F.E. DAVISON TRUCKING645032 FESSALO645030 Fiddlehead Images607192 Field & Fly Outfitters645517 FLATOUT CRACKFILLING AND

PAINTING607510 Floral Heirlooms645107 FOTOFEST645220 Freedom 24 Solutions645050 Fundy Line Restaurant645401 Fundy Shipping645301 Gagnon Consultation strategix Consulting645063 Galerie d’art Rouge-gorge Art Gallery644767 Garderie Camy612892 GE CAPITAL612893 GE CAPITAL CANADA612895 GE CAPITAL IT SOLUTIONS612894 GE SAFETYNET SOLUTIONS644951 GEO-GREEN ENERGY

INSTALLATIONS645377 Get A Grip, Or Two607583 Greenfield Technology Solutions613134 GWS Relocations645023 HAMMOND RIVER TAXI645451 Hanlon Drafting & Design344818 HB Consulting645257 HighTen Communications645031 Howe Crackfilling & Priming346953 IDEAL CAR CARE CENTRE645008 J&D Computer Consultants645088 Jessica Dawn Textiles607130 JGD Portable Sawmill645295 John Toth Trucking645414 JOHNNY’S 2 FOR 1645542 Johnson Brothers Painting645083 Julia’s Bouquet645313 Just Balloons & Party Supplies645033 Kent County Roofing645333 Knights Inn Fredericton645421 Kosmic Art Productions644997 Kyla’s Koaches644600 L’Art du Tintamarre645124 La Grande Maison Caraquet347311 LAVISH HANDCRAFTED SOAP645151 Linda’s Clipper’s & Cuts for men645052 Lobo Mechanical645237 M.T. BOTTLES645101 Mace Roofing645311 Marbax Consulting645469 Matt’s Auto & Small Engine Repair645362 McCleave & Associates645454 MD TechMedia644986 METICULOUS MOTORS645392 Mint Night Club645365 Moore Masonry645234 Morag Walks612971 MOVIE BUFFS607140 MUD RIVER HOLDINGS RGD.645532 Natures Estate Farm645154 Neil Graye Trucking

644989 Noël’s Pizzaria645291 NOTHING BUT REWARDS DOG

TRAINING645225 Nurturing From Nature Aromatherapy For

Dogs and Cats644917 Oasis Sportive BP645123 Old School Foods645524 ONE MAN AND A TRUCK

CONTRACTING645200 P.W.PARKER CONSULTANTS645108 Perland Self Storage607741 R & R DISPOSAL645096 R&F Trucks645262 R.E.R. Auto Sales607462 Rangertech Forestry645020 Raymond’s Son Tree Removal and Tree

Trimming645303 RCR Small Engine Repair644575 Reg2Play.com645290 REUSSIR EN FRANCAIS347083 RICK’S ELECTRIC645021 Ricky Moto Parts645049 Riverside Paddlers607376 Ruthie’s Tailoring645160 S.R. COMPUTER SERVICE645332 Saint John Baby Expo607282 Salon de beauté Raymonde Beauty Salon645399 Spacious Spaces Professional Organizing645074 SpruceWood Construction645046 TAMB Wear612790 TD Insurance Home and Auto / TD

Assurance Habitation et Auto607529 The Air Exchange Guys645363 THE ARCHERY OUTPOST645300 The Entrepreneurs Toolbox607450 THE SIGNMASTER326756 THE WEDDING SPECIALISTS645344 Thompson’s Adaptable Clothing645189 Tidal Watch Inn607701 TIME TRANSPORT645565 Tina’s Hair and Esthetics326633 TRANSCONTINENTAL REALTY645006 Transient Sound613033 TWEEDSIDE EVERGREENS645067 Ultimate Cleaning Services644985 UNIVERSAL CYBER TELEPORT645559 Universal Studios/Alliance Films Home

Entertainment347234 VIDEO BLOCKBUSTER CANADA645506 VIVEK AUTOMOTIVE645230 White Glove Maid Service645523 WILDERNESS BIRCH RIDGE FARM645255 Wise Choice Counselling607431 WOOD -N- WATER CREATIONS645574 WYDESKY Recording Studios333761 XTRA CANADA333763 XTRA INTERMODAL (CANADA)333762 XTRA LEASE (CANADA)645075 YARDANTICS645061 YE-A BABY! PRODUCTIONS645086 You Got To Have It Shabby Chic

Schedule “A” / Annexe « A »Certificates of Partnerships / Certificats de sociétés en nom collectif

_____________________________________________________

Schedule “B” / Annexe « B »Certificates of Business names / Certificats d’appellations commerciales

Page 10: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 410 Gazette royale — 15 avril 2015

681141 NB INC. Tracadie Sheila 681141 2015 02 22

CINEFREQ INC. Burton 681487 2015 03 25

Su Pépé Gastropub Ltée Caraquet 681528 2015 03 17

BnR General Contracting Ltd. Central Greenwich 681529 2015 03 17

Seaboard Investments Ltd. Moncton 681536 2015 03 18

Folk Media Communications Inc. Campbellton 681545 2015 03 18

Fillion Harvest Inc. Wakefield 681548 2015 03 18

681566 NB Inc. Caraquet 681566 2015 03 19

Gordon Cunningham Electrical Ltd. Hatfield Point 681567 2015 03 19

Trademark Building Products Ltd. Lower Coverdale 681569 2015 03 19

DAM Holdings Inc. Fredericton 681574 2015 03 19

681575 NB INC. Saint-Jean-Baptiste 681575 2015 03 19

Melrim Properties Inc. Saint John 681576 2015 03 19

Matt Whittaker’s Trucking Ltd. Saint John 681577 2015 03 19

681578 N.B. Inc. Dieppe 681578 2015 03 19

681579 N.B. LTD. Saint John 681579 2015 03 19

Dr. Darryl MacKenzie Professional Corporation Fredericton 681580 2015 03 19

Dr. Erin Demmings P.C. Ltd. Rothesay 681581 2015 03 19

PJT CAPITAL CORP. Dieppe 681582 2015 03 19

681583 N.B. Ltd. North View 681583 2015 03 20

ClemTech Inc. Shediac Bridge 681584 2015 03 20

ISQ Webhosting Inc. Moncton 681587 2015 03 20

Hardwired Electronics and Communications Inc. Fredericton 681588 2015 03 20

Happy Home Enterprises Inc. Miramichi 681591 2015 03 20

Zelward Enterprises Ltd. Kingston 681592 2015 03 20

681593 N.B. Ltd. Moncton 681593 2015 03 20

Casedepot Ltd. Moncton 681595 2015 03 20

681596 NB Inc. Irishtown 681596 2015 03 20

681597 NB Inc. Irishtown 681597 2015 03 20

681598 NB Inc. Irishtown 681598 2015 03 20

Loi sur les corporations commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

Page 11: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 411 Gazette royale — 15 avril 2015

NOTICE OF CORRECTION / AVIS D’ERRATUMBusiness Corporations Act / Loi sur les corporations commerciales

In relation to a certificate of incorporation issued on March 16, 2015 under the name of “681505 N.B. Inc.”, being corporation #681505, notice isgiven that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of the incorporator anddirector from “TINARONG XIANG” to “TIANRONG XIANG”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 16 mars 2015 à « 681505 N.B. Inc. », dont le numéro de corporationest 681505, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passer le nom du fondateur etde l’administrateur de « TINARONG XIANG » à « TIANRONG XIANG ».

_____________________________________________________

CREW CAB AUTO SALES LTD. Allardville 681602 2015 03 20

Epicerie St-Charles (2015) Ltée/St-Charles Grocery (2015) Ltd. Richibucto 681603 2015 03 20

Maritime Pump Technology Inc. Salisbury 681611 2015 03 20

Pêcheries Provocante Ltée Petit-Shippagan 681620 2015 03 20

Gestion Henri-Paul Bezeau Ltée Petit-Shippagan 681621 2015 03 20

East Coast Custom Logging Ltd. Pointe-à-Tom 681623 2015 03 21

681626 N.B. INC. Moncton 681626 2015 03 23

DEVAFFAIR INNOVATIVE THINKING INC. Saint John 681629 2015 03 23

Fairway Hills Inc. Fredericton 681637 2015 03 23

681638 N.B. Inc. Miramichi 681638 2015 03 23

GLENDENNING ADVERTIZING & MARKETING CONSULTANT INC.

Bathurst 681641 2015 03 23

Greener Choice Ground Care Ltd. Island View 681645 2015 03 23

CJ E-LEARNING SOLUTIONS LTD. Fredericton 681646 2015 03 23

Pilotalk Audio Inc. Fredericton 681647 2015 03 23

681652 N.-B. Inc. Saint-Joseph-de-Madawaska 681652 2015 03 24

PILA INVESTMENTS LTD. Fredericton 681653 2015 03 24

S. Bourque Optique Inc. Moncton 681654 2015 03 24

681658 NB LTD. Sussex 681658 2015 03 24

Marc Levesque Renovation Inc. Campbellton 681661 2015 03 24

FOGHORN BREWING COMPANY LTD. Upper Golden Grove 681662 2015 03 24

681665 N.B. Inc. Shediac-Bridge 681665 2015 03 24

SPARTA MANUFACTURING INC. Notre-Dame 681672 2015 03 25

681673 N.B. LTD. Saint John 681673 2015 03 25

Dr. Colleen Bray Professional Corporation Fredericton 681679 2015 03 25

Akelius Canada (II) Ltd. Moncton 681680 2015 03 25

PRODUCTIONS XTREME 14 INC. Dieppe 681682 2015 03 25

681686 NB INC. Aldouane 681686 2015 03 25

Page 12: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 412 Gazette royale — 15 avril 2015

In relation to a certificate of incorporation issued on March 19, 2015 under the name of “Trademark Building Products Ltd.”, being corporation#681569, notice is given that pursuant to s.189 of the Act, the Director has issued a corrected certificate of incorporation correcting the name of oneof the incorporators and directors from “Jason Mitton” to “Jason Milton”.

Sachez que, relativement au certificat de constitution en corporation délivré le 19 mars 2015 à « Trademark Building Products Ltd. », dont lenuméro de corporation est 681569, le directeur a délivré, conformément à l’article 189 de la Loi, un certificat d’incorporation corrigé faisant passerle nom d’un des fondateurs et administrateurs de « Jason Mitton » à « Jason Milton ».

_____________________________________________________

501359 N.B. LTD. 501359 2015 03 24

WOODS TIMBER INC. 507024 2015 03 25

RON HAYES USED CARS INC. 512008 2015 03 20

CONSOLTEX INC. 512918 2015 03 23

NICOLE AMY BRIEN DENTISTRY PROFESSIONAL CORPORATION 666343 2015 03 25

_____________________________________________________

Groupe Cormier Électrique Inc. XPERT CONTRACTORS LTD. 043332 2015 03 20

058373 N.B. Inc. EAST COAST RENTAL EQUIPMENT LIMITED 058373 2015 03 24

505188 N.B. Ltd. ACER ENVIRONMENTAL SERVICES LTD. 505188 2015 03 23

GoldPoint Partners Canada GenPar Inc. NYLCAP Canada GenPar Inc. 640575 2015 03 19

GLENDENNING ADVERTISING & MARKETING CONSULTANT INC.

GLENDENNING ADVERTIZING & MARKETING CONSULTANT INC.

681641 2015 03 25

_____________________________________________________

Rockborn Auto Inc. PENNEY-BRUSHETT INC.681184 N.B. Ltd.

Moncton 681565 2015 03 17

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment which includes a change inname has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification contenant un changement de raisonsociale a été émis à :

DatePrevious name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de fusion a été émis à :

ReferenceNumber Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

Page 13: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 413 Gazette royale — 15 avril 2015

CLINIQUE ESTHÉTIQUE MÉDICALE IMAGE / IMAGE MEDICAL AESTHETICS CLINIC INC.

Moncton 041268 2015 03 24

TJ HOLDINGS INC. Moncton 504467 2015 03 23

JOSEPH C. ROBICHAUD c.p. INC. Richibucto 507352 2015 03 24

EVANS 2000 LTD. Birdton 512189 2015 03 18

637643 NB Inc. Saint John 637643 2015 03 18

John Theologian Community Inc. Mann Mountain 646623 2015 03 23

Corporation Professionnelle Alain Bolduc MD Dermatologue Inc. Moncton 661877 2015 03 24

Top-Notch Sawmill Ltd. Browns Flat 673332 2014 11 24

Peter Thorne Lumbering Ltd. Second Falls 675376 2015 03 23

_____________________________________________________

634303 New Brunswick Ltd. Sussex POWELL ASSOCIATES LTD. 634303 2015 03 25

_____________________________________________________

Bonte Foods Ltd Nouvelle-Écosse / Nova Scotia 007470 2015 02 06

Marc Allain C.P. Inc. Moncton 610136 2015 01 26

_____________________________________________________

ALLEN’S SERVICE STATION LTD. 000443 2015 03 23

K & D TRUCKING LTD. 505686 2015 03 18

BEAULIEU LAWN CARE & SNOW REMOVAL LTD. 510499 2015 03 20

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de dissolution a été émis à :

ReferenceNumber Date

Registered Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, notice of the appointment of a receiver or a receiver-manager of the following corporations has been received:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un avis de nomination d’un séquestre ou séquestre-gérant pour lessociétés suivantes a été reçu :

Receiver or ReferenceReceiver-Manager Number Date

Registered Office Séquestre ou Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Bureau enregistré séquestre-gérant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de cessation a été émis à :

DateJurisdiction of Continuance Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Compétence de prorogation Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de reconstitution a été émis à :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Page 14: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 414 Gazette royale — 15 avril 2015

DAN ARSNEAU GENERAL CONTRACTING LTD. 601433 2015 03 24

616452 NEW BRUNSWICK LIMITED 616452 2015 03 13

F. & G. Market 2000 Inc. 646382 2015 03 18

663871 NB Inc. 663871 2015 03 23

Home Alone Pizza Inc. 664436 2015 03 24

_____________________________________________________

IMPACTORY INC. Canada Philippe AngladeMoncton

680891 2015 02 05

Marit LLC Maine McInnes Cooper CSD Services Inc.Saint John

681538 2015 03 18

BROWN’S PAVING LTD. Canada Corey McAllisterSussex Corner

681541 2015 03 18

EMU AUSTRALIA (CANADA) LTD. Territoire du Yukon /Yukon Territory

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681613 2015 03 20

CORE-MARK INTERNATIONAL, INC. Delaware Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681614 2015 03 20

INNOSPEC CANADA LIMITED Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681615 2015 03 20

ENERGY NETWORK SERVICES INC. Ontario Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681616 2015 03 20

ROAD & RAIL EQUIPMENT TECHNOLOGIES LTD.

Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681634 2015 03 23

SCT RAIL CONTRACTORS LTD. Alberta Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681635 2015 03 23

ABM ONSITE SERVICES - CANADA ULC

Colombie-Britannique /British Columbia

Stewart McKelvey CorporateServices (NB) Inc.Saint John

681650 2015 03 24

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporationhas been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a étéémis à :

ReferenceNumber Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Page 15: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 415 Gazette royale — 15 avril 2015

LUMA GÉNÉTIQUE INC. LUMA GENETIC INC.

GENETIPORC INC. 600095 2015 03 18

Apprento Inc. 9122800 Canada Inc. 680178 2015 03 19

SLEEMAN BREWERIES LTD. LES BRASSERIES SLEEMAN LTÉE

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIE SLEEMAN LTEE

680220 2015 03 17

_____________________________________________________

IA Clarington Investments Inc. JOVFINANCIAL SOLUTIONS INC.IA Clarington Investments Inc. / Placements IA Clarington Inc.

Stephen D. ChristieFredericton

681525 2015 03 17Placements IA Clarington inc.

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

1864713 ONTARIO INC.CANADA BREAD COMPANY, LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Jeff HoytSaint John

681542 2015 03 18

H & R Block Canada, Inc. H & R Block Canada, Inc. Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

681564 2015 03 19

Inmar Promotions - Canada Inc. MILLENNIUM PROCESS COUPON, INC.

Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

681649 2015 03 24

Charlotte County Rifle Association Inc. Pennfield 681551 2015 03 18

LE COMITÉ DES EXPROPRIÉS DU PARC NATIONAL KOUCHIBOUGUAC INC.

Saint-Louis 681552 2015 03 18

Mountain Bike Minto Inc. Fredericton 681604 2015 03 20

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of amendment of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat de modification de l’enregistrement de corporationextraprovinciale a été émis à :

ReferenceNumber Date

Previous name Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-tions Act, a certificate of registration of amalgamated corporationhas been issued to the following extra-provincial corporations:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovincialeissue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales sui-vantes :

ReferenceAgent and Address Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Représentant et Numéro de Year Month DayCorporation issue de la fusion Corporations fusionnantes adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :

ReferenceNumber Date

Head Office Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Siège social référence année mois jour

Page 16: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 416 Gazette royale — 15 avril 2015

ASSOCIATION DE PLANCHE A NEIGE DU MADAWASKA INC. MADAWASKA SNOWBOARD ASSOCIATION INC.

025120 2015 03 24

New Brunswick Sno Nouveau-Brunswick Inc. 628244 2015 03 24

Micmac Native Arts George Gregory Paul Red Bank 676742 2015 03 23

T Duguay Renovation Tommy Duguay Losier Settlement 681159 2015 03 23

Brothers Coe 680970 NB Corp. Saint John 681247 2015 03 23

Paul-Émile’s Auto Clinic Paul-Emile Basque McIntosh Hill 681291 2015 03 02

Miramichi Cultural Connections

Miramichi Regional Multicultural Association, Inc. /Association régionalemulticulturelle deMiramichi, Inc.

Miramichi 681483 2015 03 13

Divine Diamond Teeth Whitening

Kelly James Saint John 681495 2015 03 19

JovFinancial IA Clarington InvestmentsInc. / Placement IAClarington Inc.

Fredericton 681526 2015 03 17

Main Street West Convenience 679746 NB Ltd. Saint John 681540 2015 03 18

EASY BIN RENTALS 647992 N.B. Inc. Hanwell 681550 2015 03 18

Gowland Mountain Recording Studio

628014 N.B. Inc. Dieppe 681553 2015 03 18

BAGDAD REPAIR SHOP Kenya McKenzie Youngs Cove 681557 2015 03 19

Settlement Firewood Caleb Dickson Charters Settlement 681558 2015 03 19

EMPOWERED2LIVE - CONSULTING & COACHING

Dominique LaCroix Dieppe 681560 2015 03 19

Antique Chic Kerry Edgett Lower Coverdale 681561 2015 03 19

SIT Walk In Tub Joey Clavette Dieppe 681562 2015 03 19

GET IT THERE DELIVERY Melvin McKnight Baxters Corner 681563 2015 03 19

PUBLIC NOTICE is hereby given that the charter of the followingcompany is revived under subsection 35.1(1) of the Companies Act:

SACHEZ que la charte de la compagnie suivante est reconstituéeen vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les compagnies :

DateReference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des

appellations commercialesPartnerships and Business Names

Registration ActPUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 17: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 417 Gazette royale — 15 avril 2015

Comédie en Acadie Martin Denis Saulnier Irishtown 681573 2015 03 19

Les Entreprises A & M Annie Charest-Caron Grand-Sault / Grand Falls 681585 2015 03 20

My Gym Greater Moncton LES ENTREPRISES MAPOMA LTEE

Moncton 681589 2015 03 20

Centre de guérison Navitas Healing Center

Nathalie Lirette Memramcook 681590 2015 03 20

DUB ANTENNA MUSIC Mat Fitzgerald Fredericton 681599 2015 03 20

Toolbelt Construction Rebolledo

Jose Rebolledo Fredericton 681600 2015 03 20

Wendy Ryan Interiors Wendy Ryan Saint John 681601 2015 03 20

Skedaddle Maple GW Farms Inc. Fredericton 681605 2015 03 20

LARLEE CREEK PUBLIC HOUSE 681261 NB Ltd. Kilburn 681607 2015 03 20

G1 Concept LA PETITE IMPRIMERIE LTEE Caraquet 681608 2015 03 20

Silgo Line LA PETITE IMPRIMERIE LTEE Caraquet 681609 2015 03 20

Promotions Blanchard/Blanchard Promotions

LA PETITE IMPRIMERIE LTEE Caraquet 681610 2015 03 20

Madawaska Insurance / Assurance

Shaw Insurance Group Inc. Grand-Sault / Grand Falls 681612 2015 03 20

Respiro Dancewear Rokaya Duval Moncton 681617 2015 03 20

Walter’s Table Vertaline Steeves Woodstock 681619 2015 03 20

Equarius Canada Amanda Bennett Gagetown 681622 2015 03 21

MJW CREATIONS Michael Wright Lincoln 681624 2015 03 23

TIDE HEAD SERVICE STATION Denis Walters Tide Head 681625 2015 03 23

JB PRODUCTIONS John Borbely Quispamsis 681627 2015 03 23

READY FOR HIRE TESTING SERVICES

David Barnes Quispamsis 681628 2015 03 23

de Hart & Associates PrivateWealth Management

INVESTORS GROUP FINANCIAL SERVICES INC./SERVICESFINANCIERS GROUPEINVESTORS INC.

Saint John 681630 2015 03 23

Pretty & Polished Esthetics and MediSpa

Meliala MacDougall Fredericton 681636 2015 03 23

ECO-SHIFT PROPERTY MANAGEMENT

Garnet Thompson Sainte-Marie-de-Kent 681642 2015 03 23

Chocolate River Yarns & Fibres

Sue Phillips Riverview 681644 2015 03 23

ASAP Delivery Services Martin Robichaud Moncton 681648 2015 03 23

Mobile Ace Small Engine Services

Michel Gagnon Dieppe 681651 2015 03 24

Miramichi Rock N Run Valerie ComeauRalph WillistonLaura Roche

Miramichi 681655 2015 03 20

Page 18: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 418 Gazette royale — 15 avril 2015

GR Gerry’s Service Centre Gerald Raworth Pine Glen 681667 2015 03 24

New Maryland Yard Equipment Glenn Hallingham Charters Settlement 681669 2015 03 24

_____________________________________________________

BULK BARN PAPN ENTERPRISES Rothesay 316870 2015 03 20

NATIONAL KEY THINGS ENGRAVED INC. Saint John 322441 2015 03 18

MISTER MINIT THINGS ENGRAVED INC. Saint John 322442 2015 03 18

LES PRODUITS DORE PRODUCTS Ruth S. Wheatley Upper Coverdale 334857 2015 03 20

HUGH MCLAUGHLIN CARPENTRY SERVICES

Hugh McLauglin Fredericton 335313 2015 03 18

Primerica PFSL INVESTMENTS CANADA LTD.

Fredericton 349110 2015 03 17

EDDY WATER CONDITIONING Tracy Eddy Bathurst 349297 2015 03 25

DHL CANADA DHL EXPRESS (CANADA), LTD.DHL EXPRESS (CANADA), LTÉE

Saint John 608529 2015 03 05

KING STREET SPORTS John Kitchen Woodstock 609447 2015 03 19

Clinique de Naturopathie Debby Anne Wilson

Debby Anne Wilson Campbellton 611019 2015 03 21

CLN HEALTH SERVICES Carol Nicholson Riverview 611316 2015 03 22

CITY GLASS CITY GLASS & LOCKS LTD. Bathurst 615883 2015 03 21

DOWD ROOFING DOWD HOME IMPROVEMENTS LTD.

Saint John 616156 2015 03 23

TC Excavation Entreprise Tony Chasse Saint-Jacques 616566 2015 03 23

NORCO TRANSMISSION SERVICE (1994)

058568 N.B. LTD. Fredericton 616644 2015 03 18

DINGEE’S ENERGY SYSTEMS Brian Dingee Centreville 616682 2015 03 17

The Pampered Damsel Tiffany Carson Moncton 617184 2015 03 19

BEAMAN’S SERVICE CENTRE BEAMANS AUTO SERVICESPECIALISTS INC.

Moncton 618170 2015 03 23

Favourite Trends Imports and Distribution

Stephen Little St. Stephen 638721 2015 03 21

IA Advisor Portfolio Services / Services-conseils de gestion de portefeuilles IA

IA Clarington InvestmentsInc./Placements IAClarington Inc.

Fredericton 643951 2015 03 17

Mapleton Dental Centre DR. MARK MACINTOSHPROFESSIONAL CORPORATION

Saint John 647261 2015 03 19

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of businessname has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business ReferenceCertificate or Agent Number DateEnregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour

Page 19: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 419 Gazette royale — 15 avril 2015

BEN’S CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 648280 2015 03 18

BEN’S BAKERY CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 648281 2015 03 18

DEMPSTER’S CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 648283 2015 03 18

Portail canadamunicipal Brigitte Cladère Bas-Caraquet 648963 2015 03 24

BON MATIN CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649171 2015 03 18

BON MATIN BAKERY CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649172 2015 03 18

BOULANGERIE BEN’S CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649173 2015 03 18

BOULANGERIE BON MATIN CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649174 2015 03 18

BOULANGERIE DEMPSTER’S CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649175 2015 03 18

BOULANGERIE POM CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649176 2015 03 18

CANADA BREAD CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649177 2015 03 18

DEMPSTER’S BAKERY CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649178 2015 03 18

MULTI-MARQUES CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649179 2015 03 18

POM CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649180 2015 03 18

POM BAKERY CANADA BREAD COMPANY,LIMITED/BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE

Saint John 649181 2015 03 18

Vintage Revival Home Décor & Design

Lynn Pierpoint-Mallet Fredericton 649184 2015 03 19

Complete bookkeeping & Income Tax Services

Roger Barton Riverview 649188 2015 03 17

RANGE LOGGING Maxine Keenan Quispamsis 649263 2015 03 20

SMS Rents SMS Construction andMining Systems Inc./Systèmes de Constructionet Mines SMS Inc.

Fredericton 649296 2015 03 24

Page 20: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 420 Gazette royale — 15 avril 2015

Location SMS SMS Construction andMining Systems Inc./Systèmes de Constructionet Mines SMS Inc.

Fredericton 649297 2015 03 24

IA Private Client / IA Gestion privée

IA Clarington Investments Inc.Placements IA Clarington inc.

Fredericton 649318 2015 03 17

Pedro’s Taco Peter Lafford Elsipogtog 649416 2015 03 19

BAMBERGER POLYMERS CANADA

BAMBERGER POLYMERS (CANADA) CORP./POLYMERES BAMBERGER (CANADA) CORP.

Saint John 649833 2015 03 19

Salon Carrousel enr. Nicole Dugas Tracadie-Sheila 649902 2015 03 19

Spartan Janitorial Arlene Alcock Moncton 650064 2015 03 23

RJO Canada Online R.J. O’Brien & AssociatesCanada Inc.

Saint John 650171 2015 03 25

Westworld Tours Saskatchewan Motor ClubServices Limited

Saint John 650222 2015 03 19

SNC-Lavalin O&M SNC-LAVALIN OPERATIONS & MAINTENANCE INC.

Fredericton 650284 2015 03 24

Pfaff Leasing PFAFF MOTORS INC. Saint John 664521 2015 03 11

_____________________________________________________

MY GYM GREATER MONCTON Riverview 639735 2015 03 20

Services Administratifs Sonia Savoie Administrative Services Balmoral 648737 2015 03 19

JOVFINANCIAL SOLUTIONS Fredericton 650831 2015 03 17

Gastropub Su Pépé Saint-Simon 667236 2015 03 20

Les Entreprises A & M Grand-Sault / Grand Falls 672897 2015 03 20

NABORS CANADA Saint John 674435 2015 03 25

RYAN DIRECTIONAL SERVICES Saint John 674436 2015 03 25

Hardwired Communications Keswick Ridge 675264 2015 03 20

KiPi Awakenings Dieppe 677652 2015 03 19

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-merciale a été enregistré :

ReferenceNumber Date

Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Adresse référence année mois jour

Page 21: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 421 Gazette royale — 15 avril 2015

ACCOMODATIONS VICTORIA ENR. Benoit BosséEdmundston

322260 2015 03 17

THE BACARDI RUM COMPANY Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

601567 2015 03 23

ExxonMobil Business Support Centre McInnes Cooper CSD Services Inc.Fredericton

615049 2015 03 18

ExxonMobil Business Support Centre Canada McInnes Cooper CSD Services Inc.Fredericton

615050 2015 03 18

Casdon Canada Co. Stewart McKelvey Corporate Services (NB) Inc.Saint John

672713 2015 03 23

_____________________________________________________

FM Sky Vision Martin ThibodeauFrancois d’Entremont

Moncton 680921 2015 03 23

Piggie’s Cove Olivia Louise SegsworthJan Henry Sanders

Saint Andrews 680998 2015 03 19

OK My Dear Vintage Julie AubeKatrine Noel

Moncton 681405 2015 03 18

Majestic Gardens Peter James AdamsSarah Catherine Adams

Quispamsis 681504 2015 03 16

LUMITECNIK LED LIGHTING SOLUTIONS

Jeffrey BakerTyson Baker

Tilley 681571 2015 03 25

Watertech Hydrographics Brandon Wayne HébertJeremy William ParkerJustin Thaddée Parker

Moncton 681572 2015 03 19

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of change of agent forservice has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

ReferenceNumber Date

Agent and Address / Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of partnership hasbeen registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Referenceor Agent Number DateAdresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

Page 22: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 422 Gazette royale — 15 avril 2015

Cattail Ridge Family Market Frances WeldonMichael Weldon

Sackville 638177 2015 03 20

Lincoln Pet Hotel Kelly Ann LemieuxBlaine Duff

Lincoln 649399 2015 03 18

Positive Heart Living Kevin Joseph DouglassBonnie Clark Douglass

Fredericton 649452 2015 03 20

Dooryard Greenhouse John MorrisNanette MacDonald-Morris

Florenceville-Bristol 649498 2015 03 16

Neptune Peak Limited Partnership Cemix Properties, LLC Saint John 681523 2015 03 17

DTA Management Limited Partnership DTA International Limited

Saint John 681539 2015 03 18

_____________________________________________________

VENTAS CANADA RETIREMENT I LP

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

663156 2015 03 19

VENTAS CANADA RETIREMENT III LP

Saint John Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

663157 2015 03 19

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships andBusiness Names Registration Act, a certificate of renewal of part-nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés ennom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-nouvellement de société en nom collectif a été enregistré :

Address ofBusiness or Agent ReferenceAdresse du Number Datecommerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres du représentant référence année mois jour

Loi sur les sociétés en commanditeLimited Partnership Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of limited partnership has been filed by:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite a été déposée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership hasbeen filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale a été dépo-sée par :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Agent and Address Number DatePrincipal établissement au Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Nouveau-Brunswick Compétence et adresse référence année mois jour

Page 23: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 423 Gazette royale — 15 avril 2015

SPROTT BRIDGING INCOME FUND LP

Fredericton Ontario Steven D. ChristieFredericton

672738 2015 03 18

_____________________________________________________

VENTAS CANADA RETIREMENT I LP

Holiday Canada Retirement LP

Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

663156 2015 03 19

VENTAS CANADA RETIREMENT III LP

Holiday Canada Retirement III LP

Ontario Stewart McKelveyCorporate Services(NB) Inc.Saint John

663157 2015 03 19

SPROTT BRIDGING INCOME FUND LP

Bridging Credit Fund LP Ontario Steven D. ChristieFredericton

672738 2015 03 18

_____________________________________________________

TCL FUNDING LIMITED PARTNERSHIP

Ontario Dollar ThirtyAutomotive GroupCanada Inc.

Saint John 400492 2015 03 24

VENTAS CANADA RETIREMENT I LP

Nouvelle-Écosse /Nova Scotia

Ventas Canada Retirement IGP ULC

Saint John 663156 2015 03 19

VENTAS CANADA RETIREMENT III LP

Nouvelle-Écosse /Nova Scotia

Ventas CanadaRetirement IIIGP ULC

Saint John 663157 2015 03 19

SPROTT BRIDGING INCOME FUND LP

Ontario Sprott Genpar Ltd. Fredericton 672738 2015 03 18

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of extra-provincial limited partnership,which includes a name change, has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de société en commandite extraprovinciale, contenantune nouvelle raison sociale, a été déposée par :

ReferenceAgent and Address Number Date

Previous Name Jurisdiction Représentant Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Ancienne raison sociale Compétence et adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partner-ship Act, a declaration of change of limited partnership or extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, unedéclaration de changement de société en commandite ou de sociétéen commandite extraprovinciale a été déposée :

Principal place in ReferenceNew Brunswick Number Date

Jurisdiction General Partners Principal établissement au Numéro de Year Month DayName / Raison sociale Compétence Commandités Nouveau-Brunswick référence année mois jour

Page 24: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 424 Gazette royale — 15 avril 2015

Avis de consultation publique sur une étude d’impact sur l’environnement

Conformément aux alinéas 13 b) et d) du Règlement sur lesétudes d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissementde l’environnement, je, Brian Kenny, ministre de l’Environne-ment et des Gouvernements locaux, invite le public à présenterdes mémoires écrits et à participer à la séance publique prévuepour le 22 juin 2015 concernant l’étude d’impact sur l’environ-nement d’un projet qui propose d’exploiter une mine detungstène et de molybdène à ciel ouvert et une usine de traite-ment par Sisson Mines Limited, planifié au sud-est de la com-munauté de Napadogan (Nouveau-Brunswick).

La séance publique aura lieu le 22 juin 2015 à partir de 19 hdans le gymnase de l’école secondaire de Stanley, 28, rueBridge, Stanley (N.-B.).

Pour faire une présentation dans la cadre de la réunion publique,veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement etdes Gouvernements locaux au 506-453-3700. Les services detraduction simultanée seront assurés à la rencontre publique. Sivous avez besoin de services d’interprétation gestuelle, prièrede composer le 506-633-0599 (TTY).Les mémoires écrits concernant le projet doivent être soumisdans la langue officielle de votre choix au plus tard le 17 juillet2015 à la Direction de l’éducation et l’engagement, Ministèrede l’Environnement et des Gouvernements locaux, 20, rueMcGloin, Place Marysville, 3e étage, Fredericton (N.-B.)E3A 5T8, téléphone : 506 453-3700, télécopieur : 506453-3676, adresse électronique : [email protected] le cadre de l’obligation de la Couronne de consulter au su-jet de l’étude d’impact sur l’environnement du projet proposépar Sisson Mines Limited, une série de réunions communau-taires des Premières Nations auront également lieu. Ceux-ci se-ront organisés en consultation avec les communautés respec-tives.Des copies du sommaire du rapport de l’étude d’impact sur l’en-vironnement et de la déclaration générale de révision sont ac-cessibles aux endroits indiqués ci-dessous :

• Burtts Corner : Birds Corner Store, 002, route 104• Florenceville-Bristol : bureau d’administration munici-

pale, 4724, chemin Juniper• Fredericton : Ministère de l’Environnement et des Gou-

vernements locaux, 20, rue McGloin (Place Marysville);Bibliothèque publique de Fredericton, 12, rue Carleton;Bibliothèque publique Nashwaaksis, 324, avenue Fulton

• Juniper : Mills Convenience Store, 6765, route 107• Millville : bureau d’administration municipale, 39, che-

min Howland Ridge• Nackawic : bureau d’administration municipale,

26, chemin Pinder• Stanley : bureau d’administration municipale, 20, rue

Main; Bibliothèque communautaire de Stanley, 28, rueBridge, pièce 2, Hillside Convenience, 30, rue Main

Ministère de l’Environnementet des Gouvernements locaux

Notice of Public Consultation Environmental Impact Assessment

Under section 13, paragraphs (b) and (d) of the EnvironmentalImpact Assessment Regulation - Clean Environment Act, I, theHonourable Brian Kenny, Minister of Environment and LocalGovernment give public notice that I am inviting members of thepublic to submit written briefs and to participate in a public meet-ing to be held on June 22, 2015 concerning the environmental im-pact assessment for the proposed tungsten and molybdenumopen pit mine and processing plant by Sisson Mines Limited,located southwest of the community of Napadogan, NewBrunswick.

The public meeting will be held on June 22, 2015, beginningat 7:00 p.m. in the Stanley High School gymnasium,28 Bridge Street, Stanley, NB.

To register to make a presentation at the public meeting, pleasecontact the New Brunswick Department of Environment andLocal Government at (506) 453-3700. Simultaneous Interpreta-tion will be provided at the public meeting. If you require signlanguage interpretation, please call (506) 633-0599 (TTY).

Written briefs concerning the undertaking should be submitted inthe official language of your choice no later than July 17, 2015 tothe Education and Engagement Branch, Department of Environ-ment and Local Government, 20 McGloin Street, MarysvillePlace, 3nd Floor, Fredericton, N.B. E3A 5T8, Tel: (506) 453-3700,Fax: (506) 453-3676, e-mail: [email protected].

As part of the Crown’s duty to consult on the environmental im-pact assessment for the project proposed by Sisson Mines Lim-ited, a series of First Nations community meetings will also beheld. These will be scheduled in consultation with the respec-tive communities.

Copies of the Summary of the EIA Report and the General Re-view Statement are available at the following locations:

• Burtts Corner: Birds Corner Store, 002, Route 104• Florenceville-Bristol: Town office, 4724 Juniper Road

• Fredericton: Department of Environment and LocalGovernment, 20 McGloin Street (Marysville Place);Fredericton Public Library, 12 Carleton Street;Nashwaaksis Public Library, Nashwaaksis MiddleSchool, 324 Fulton Avenue

• Juniper: Mills Convenience Store, 6765, Route 107• Millville: Village office, 39 Howland Ridge Road

• Nackawic: Town office, 26 Pinder Road

• Stanley: Village office, 20 Main Street, Stanley Commu-nity Library, 28 Bridge Street, Unit 2, Hillside Conve-nience, 30 Main Street

Department of Environment and Local Government

Page 25: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 425 Gazette royale — 15 avril 2015

• Tay Creek: Tay Creek Country Store, 3789, Route 620• Woodstock: Town office, 824 Main Street

Copies of the complete EIA Report are available for referencingat the municipal offices and libraries listed above. All docu-ments are accessible online at www.gnb.ca/environment.

SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after April 15, 2015:

2009 Chevrolet CobaltSerial No. 1G1AT15H597137755License Plate: GXA 631Registered Owner: Samuel Joseph PageVehicle located at All Rite Auto out of Waterville, NB

________________

SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after April 15, 2015:

2001 Honda CivicSerial No. 2HGES16371H926644License Plate: not platedRegistered Owner: Nathan Lawrence AustinVehicle located a Five Star Towing out of Lakeville, NB

2001 Dodge DakotaSerial No. 1B7GL22N41S319580License Plate: CJG169Registered Owner: Kevin Edward LandryVehicle located a Five Star Towing out of Lakeville, NB

________________

SALE OF MOTOR VEHICLESTake notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province ofNew Brunswick, will be disposing of the following vehicles onor after April 15, 2015:

2004 Mitsubishi EclipseSerial No. 4A3AK24F86E601061License Plate: JCJ361Registered Owner: Brian Patrick MarusiakVehicle located at CMV Towing & Recovery Ltd. out ofQuispamsis, NB

Department ofPublic Safety

• Tay Creek : Tay Creek Country Store, 3789, route 620• Woodstock : bureau d’administration municipale,

824, rue Main

Des exemplaires du rapport complet de l’étude d’impact surl’environnement sont disponibles aux bureaux d’administrationmunicipale et aux bibliothèques indiqués ci-dessus commesource de référence. La documentation est également dispo-nible en ligne à www.gnb.ca/environnement.

VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 15 avril 2015 :

Chevrolet Cobalt 2009Numéro de série : 1G1AT15H597137755Numéro d’immatriculation : GXA 631Propriétaire immatriculé : Samuel Joseph PageVéhicule se trouvant actuellement chez All Rite Auto deWaterville (N.-B.)

________________

VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 15 avril 2015 :

Honda Civic 2001Numéro de série : 2HGES16371H926644Numéro d’immatriculation : pas immatriculéPropriétaire immatriculé : Nathan Lawrence AustinVéhicule se trouvant actuellement chez Five Star Towing deLakeville (N.-B.)Dodge Dakota 2001Numéro de série : 1B7GL22N41S319580Numéro d’immatriculation : CJG169Propriétaire immatriculé : Kevin Edward LandryVéhicule se trouvant actuellement chez Five Star Towing deLakeville (N.-B.)

________________

VENTE DE VÉHICULES À MOTEURSachez que le registraire des véhicules à moteur de la provincedu Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteursuivants le 15 avril 2015 :

Mitsubishi Eclipse 2004Numéro de série : 4A3AK24F86E601061Numéro d’immatriculation : JCJ361Propriétaire immatriculé : Brian Patrick MarusiakVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing & Re-covery Ltd., de Quispamsis (N.-B.)

Ministère de laSécurité publique

Page 26: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 426 Gazette royale — 15 avril 2015

1998 Toyota CorollaSerial No. 2T1BR12E8WC735286License Plate: BVT124Registered Owner: Zachary Kane TheriaultVehicle located at CMV Towing & Recovery Ltd. out ofQuispamsis, NB2002 Mazda ProtegéSerial No. JM1BJ225020545760License Plate: GFN400Registered Owner: Gerald Joseph GuidryVehicle located at CMV Towing & Recovery Ltd. out ofQuispamsis, NB

Public notice of change of registered nameunder the Change of Name Act, chapter 103, ss.10(2)

of the Revised Statutes of New Brunswick, 2014

Previous Registered Name: Edgar LazaryanNew Registered Name: Edgar LazarAddress: Fredericton, NBDate Granted: December 3, 2014

Previous Registered Name: Anna MkrtchyanNew Registered Name: Anna LazarAddress: Fredericton, NBDate Granted: December 3, 2014

Previous Registered Name: Marie Délia ThibodeauNew Registered Name: Cecile Delia DeschampsAddress: Saint John, NBDate Granted: December 4, 2014

Previous Registered Name: Alexandre Joseph FrançoisLadouceur

New Registered Name: Alexandre Joseph FrançoisLadouceur LeBlanc

Address: Moncton, NBDate Granted: December 4, 2014

Previous Registered Name: Charles BillsNew Registered Name: Robert Charles ReeseAddress: Fredericton, NBDate Granted: December 11, 2014

Previous Registered Name: Jihyun YooNew Registered Name: Kelly Jihyun YooAddress: Grand-Barachois, NBDate Granted: December 18, 2014

Previous Registered Name: Jennifer Wendy DugasNew Registered Name: Jennifer Wendy AndersonAddress: Pennfield, NBDate Granted: December 23, 2014

Josée DubéRegistrar General of Vital Statistics

Service New Brunswick

Toyota Corolla 1998Numéro de série : 2T1BR12E8WC735286Numéro d’immatriculation : BVT124Propriétaire immatriculé : Zachary Kane TheriaultVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing & Re-covery Ltd., de Quispamsis (N.-B.)Mazda Protegé 2002Numéro de série : JM1BJ225020545760Numéro d’immatriculation : GFN400Propriétaire immatriculé : Gerald Joseph GuidryVéhicule se trouvant actuellement chez CMV Towing & Re-covery Ltd., de Quispamsis (N.-B.)

Avis public de changement de noms enregistrés en application de la Loi sur le changement de nom, lois

révisées du Nouveau-Brunswick de 2014, c.103, par.10(2)

Ancien nom enregistré : Edgar LazaryanNouveau nom enregistré : Edgar LazarAdresse : Fredericton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 3 décembre 2014

Ancien nom enregistré : Anna MkrtchyanNouveau nom enregistré : Anna LazarAdresse : Fredericton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 3 décembre 2014

Ancien nom enregistré : Marie Délia ThibodeauNouveau nom enregistré : Cecile Delia DeschampsAdresse : Saint John (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 4 décembre 2014

Ancien nom enregistré : Alexandre Joseph FrançoisLadouceur

Nouveau nom enregistré : Alexandre Joseph FrançoisLadouceur LeBlanc

Adresse : Moncton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 4 décembre 2014

Ancien nom enregistré : Charles BillsNouveau nom enregistré : Robert Charles ReeseAdresse : Fredericton (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 11 décembre 2014

Ancien nom enregistré : Jihyun YooNouveau nom enregistré : Kelly Jihyun YooAdresse : Grand-Barachois (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 18 décembre 2014

Ancien nom enregistré : Jennifer Wendy DugasNouveau nom enregistré : Jennifer Wendy AndersonAdresse : Pennfield (N.-B.)Date d’accueil de la demande : Le 23 décembre 2014

Josée DubéRegistraire générale des statistiques

de l’état civil

Services Nouveau-Brunswick

Page 27: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 427 Gazette royale — 15 avril 2015

REQUEST FOR COMMENTSNotice and Request for CommentPublishing for comments proposed amendments to MultilateralInstrument 62-104 Take-Over Bids and Issuer Bids, ProposedChanges to National Policy 62-203 Take-Over Bids and IssuerBids as well as proposed consequential amendments to:

• Multilateral Instrument 11-102 Passport System;• Multilateral Instrument 13-102 System Fees for SEDAR

and NRD;• National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for

Mineral Projects;• Multilateral Instrument 51-105 Issuers Quoted in the U.S.

Over-the-Counter Markets;• Companion Policy 55-104CP Insider Reporting Require-

ments and Exemptions;

• National Instrument 62-103 The Early Warning Systemand Related Take-Over Bids and Insider Reporting Is-sues; and

• Implementing Instrument 71-802 adopting National In-strument 71-101 The Multijurisdictional DisclosureSystem.

(Together, the proposed amendments).

IntroductionOn 26 January 2015, the Financial and Consumer ServicesCommission (Commission) approved publication in order toobtain comments on the proposed amendments.

Substance and Purpose of Proposed AmendmentsOn March 14, 2013, the Canadian Securities Administrators(CSA) published for comment proposed National Instrument62-105 Security Holder Rights Plans and proposed CompanionPolicy 62-105CP. The Autorité des marchés financiers, whileparticipating in the publication for comment of the CSA pro-posal, concurrently published a consultation paper entitled AnAlternative Approach to Securities Regulators’ Intervention inDefensive Tactics.

On September 11, 2014, the CSA published CSA Notice 62-306Update on Proposed National Instrument 62-105 SecurityHolder Rights Plans and AMF Consultation Paper An Alterna-tive Approach to Securities Regulators’ Intervention in Defen-sive Tactics. As indicated in the Notice, in light of the commentsreceived on the previous proposals, and following further re-flection and analysis, the CSA decided to propose specificamendments to the bid regime as an alternative harmonized pol-icy approach for the regulation of take-over bids.

Financial and Consumer Services Commission

DEMANDE DE COMMENTAIRESAvis de publication et demande de commentairesPublication en vue de recueillir des commentaires sur le projetde modifications à la Norme multilatérale 62-104 sur les offrespubliques d’achat et de rachat et l’Instruction générale cana-dienne 62-203 relative aux offres publiques d’achat et de rachatainsi que les Projets de modifications corrélatives suivantes :

• la Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport;• la Norme multilatérale 13-102 sur les droits relatifs aux

systèmes de SEDAR et de la BDNI;• la Norme canadienne 43-101 sur l’information concer-

nant les projets miniers;• la Norme multilatérale 51-105 sur les émetteurs cotés sur

les marchés de gré à gré américains;• l’Instruction complémentaire relative à la Norme multila-

térale 55-104 sur les exigences et dispenses de déclara-tion d’initié;

• la Norme canadienne 62-103 sur le système d’alerte etquestions connexes touchant les offres publiques et lesdéclarations d’initiés; et

• la Norme de mise en application 71-802 mettant en œuvrela Norme canadienne 71-101 sur le régime d’informationmultinational.

(Collectivement, les modifications proposées).

IntroductionLe 26 janvier 2015, la Commission des services financiers etdes services aux consommateurs (la Commission) a approuvé lapublication dans le but de recueillir des commentaires sur lesmodifications proposées.

Substance et objet des modifications proposées Le 14 mars 2013, les Autorités canadiennes en valeurs mobi-lières (les « ACVM ») ont publié pour consultation le projet deNorme canadienne 62-105 sur les régimes de droits des por-teurs et le projet d’Instruction complémentaire relative à laNorme canadienne 62-105. L’Autorité des marchés financiers,tout en participant à la publication pour consultation de la pro-position des ACVM, a publié simultanément un document deconsultation intitulé Un regard différent sur l’intervention desautorités en valeurs mobilières dans les mesures de défense.Le 11 septembre 2014, les ACVM ont publié l’Avis 62-306 desACVM, Le point sur le projet de Norme canadienne 62-105 surles régimes de droits des porteurs et sur le document de consul-tation de l’Autorité, Un regard différent sur l’intervention desautorités en valeurs mobilières dans les mesures de défense.Comme l’indiquait cet avis, à la lumière des commentaires surles propositions précédentes, et après mûre réflexion et analyse,les ACVM ont décidé de proposer des modifications du régimedes offres publiques d’achat (« OPA ») pour instaurer une autreapproche harmonisée de réglementation.

Commission des services financiers et des services

aux consommateurs

Page 28: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 428 Gazette royale — 15 avril 2015

Presently, the proposed amendments’ key objectives are the fol-lowing:

• to reduce the risk of structural coercion in take-over bidscaused by the inability of target company shareholders torespond collectively to a hostile bid, and

• to provide target company boards with additional time torespond to a hostile bid.

The proposed amendments will serve to harmonize require-ments for take-over bids and issuer bids in all jurisdictions ofCanada.

Request for CommentThe Commission welcomes your comments on the proposedamendments as they apply to New Brunswick only.

How to Obtain a Copy and Provide your Comments

The texts of the above-noted proposed amendments as well as amore detailed notice can be obtained from the Commission’swebsite: www.fcnb.ca.

Comments are to be provided, in writing, by no later than29 June 2015 to:

SecretaryFinancial and Consumer Services Commission85 Charlotte Street, Suite 300Saint John, N.B. E2L 2J2Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 866-933-2222 (within NB only)Fax: 506-658-3059E-mail: [email protected]

We cannot guarantee the confidentiality of the submissions wereceive. A summary of the written comments received duringthe comment period may be published.

QuestionsIf you have any questions, please refer them to:

Kevin HoytExecutive Director of SecuritiesFinancial and Consumer Services CommissionTel: 506-643-7691Email: [email protected]

Présentement, les objectifs principaux des modifications propo-sées consistent à :

• réduire le risque de coercition structurelle dans les OPA,induite par l’incapacité des actionnaires de la société vi-sée à répondre collectivement à une OPA hostile; et

• fournir au conseil d’administration de la société visée undélai supplémentaire pour répondre à une OPA hostile.

Les modifications auront pour effet d’harmoniser les offres pu-bliques d’achat et de rachat dans l’ensemble des provinces etdes territoires canadiens.

Demande de commentairesLa Commission désire prendre connaissance de vos commen-taires au sujet des modifications proposées, mais uniquementdans la mesure où elles s’appliquent au Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir un exemplaire et nous présenter vos commentairesOn trouvera les textes des modifications proposées ci-dessuspar l’entremise du site web de la Commission : www.fcnb.ca.

Les commentaires doivent être envoyés par écrit au plus tard le29 juin 2015 à l’adresse suivante :

SecrétaireCommission des services financiers et des services aux consommateurs85, rue Charlotte, bureau 300Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2Téléphone : 506-658-3060Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement)Télécopieur : 506-658-3059Courriel : [email protected]

Nous ne pouvons pas garantir la confidentialité des commen-taires que nous recevrons. Il se pourrait que nous publiions unrésumé des commentaires écrits que nous recevrons pendant lapériode de consultation.

QuestionsSi vous avez des questions, veuillez communiquer avec :

Kevin HoytDirecteur, valeurs mobilièresCommission des services financiers et des services aux consommateurs Tél. : 506-643-7691 Courriel : [email protected]

Page 29: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 429 Gazette royale — 15 avril 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Gaetan Boucher and Joseph Jean Boucher, original Mort-gagors and owners of the equity of redemption; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the mortgageand the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Free-hold property situate at 30 Grondin Street, Saint-Jacques, in theCounty of Madawaska and Province of New Brunswick, andbeing identified as PID 35042514.Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, Mort-gagee and holder of the mortgage. Sale to be held at the Officesof the Carrefour Assomption, 121 Church Street, Edmundston,NB on April 23, 2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. Seeadvertisement of Notice of Mortgage Sale in Le Madawaska onSaturdays dated March 28, April 4, April 11 and April 18, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,Per: Natalie M. Stewart, Suite 1700, Brunswick Square,1 Germain Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick,E2L 4R8, Telephone: 506-643-6500, Facsimile: 506-643-6505

________________

ESTATE MAUREEN LANDRY / ESTATE MAUREENELIZABETH LANDRY, formerly of 404 Wallace Street atDalhousie, in the County of Restigouche and Province of NewBrunswick, Mortgagor and owner of the equity of redemption;CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION,holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM ITMAY CONCERN.Freehold premises situate, lying and being at 404 Wallace Streetat Dalhousie, in the County of Restigouche and Province ofNew Brunswick, known as PID 50101344.Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage.

Sale to be held on May 1st, 2015, at 11:00 a.m., at the Clerk’sOffice located at 157 Water Street, at Campbellton, in theCounty of Restigouche and Province of New Brunswick.See advertisement in the newspaper The Tribune, editions ofApril 3rd, April 10th, April 17th and April 24th, 2015.Dated at Edmundston, New Brunswick, this 11th day of March,2015.

GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, So-licitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation

________________

Notices of Sale

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataires : Gaetan Boucher et Joseph Jean Boucher, débi-teurs hypothécaires originaires et propriétaires du droit de ra-chat; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au30, rue Grondin, à Saint-Jacques, comté de Madawaska, pro-vince du Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 35042514.Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-cière hypothécaire et titulaire de l’hypothèque. La vente auralieu le 23 avril 2015, à 11 h, heure locale, au Carrefour Assomp-tion, 121, rue de l’Église, Edmundston (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions du 28 mars et des4, 11 et 18 avril 2015 du journal Le Madawaska.

Natalie M. Stewart, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laBanque Toronto-Dominion, Brunswick Square, bureau 1700,1, rue Germain, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

LA SUCCESSION DE MAUREEN LANDRY / MAUREENELIZABETH LANDRY, anciennement du 404, rue Wallace,à Dalhousie, comté de Restigouche, province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire et propriétaire du droit de ra-chat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADAEST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTREINTÉRESSÉ ÉVENTUEL.Lieux en tenure libre situés au 404, rue Wallace, à Dalhousie,comté de Restigouche, province du Nouveau-Brunswick, etdont le NID est 50101344.Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypo-thèque.La vente aura lieu le 1er mai 2015, à 11 h, au bureau du greffier,157, rue Water, Campbellton, comté de Restigouche, provincedu Nouveau-Brunswick.Voir l’annonce publiée dans les éditions des 3, 10, 17 et 24 avril2015 du journal The Tribune.Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 11 mars 2015.

GARY J. McLAUGHLIN, c.r., Cabinet Juridique McLaughlin,avocats et représentants de CitiFinancière, corporation duCanada Est

________________

Avis de vente

Page 30: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 430 Gazette royale — 15 avril 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Eleanor Marie Murphy (estate), original Mortgagor; and toall others whom it may concern. Sale pursuant to terms of theMortgage and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Actsin amendment thereof. Freehold property being situated at602 Route 740, Heathland, New Brunswick, the same lot con-veyed to Eleanor Marie Murphy by Deed registered in the Char-lotte County Registry Office on September 23, 1981 as number91236 and by Application of Survivor registered in the Land Ti-tles Office on February 16, 2009, as document number26831496.

Notice of Sale given by Investors Group Trust Co. Ltd. Sale tobe held at the St. Stephen Town Hall, located at 73 MilltownBoulevard, St. Stephen, New Brunswick, on the 30th day ofApril, 2015, at the hour of 1:15 p.m., local time. See advertise-ment of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated April 1,April 8, April 15 and April 22, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Investors Group Trust Co. Ltd.,Per: Kathryn L. Stratton, Blue Cross Centre, 644 Main Street,Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick,E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Wayne Wilfred Toole, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 243-245 LutzStreet, Moncton, New Brunswick, the same lot conveyed toWayne Wilfred Toole by Transfer registered in the Land TitlesOffice on June 23, 2005, as document number 20471075.

Notice of Sale given by Investors Group Trust Co. Ltd. Sale tobe held at Moncton City Hall located at 655 Main Street,Moncton, New Brunswick, on the 30th day of April, 2015, at thehour of 11:15 a.m., local time. See advertisement of Notice ofSale in the Times & Transcript dated April 1, April 8, April 15and April 22, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Investors Group Trust Co. Ltd.,Per: Kathryn L. Stratton, Blue Cross Centre, 644 Main Street,Suite S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick,E1C 8T6, Telephone: 506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataire : La succession d’Eleanor Marie Murphy, débitricehypothécaire originaire; et tout autre intéressé éventuel. Venteeffectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et decelles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens entenure libre situés au 602, route 740, à Heathland (Nouveau-Brunswick), et correspondant au même lot ayant été transféré àEleanor Marie Murphy par l’acte de transfert enregistré au bu-reau de l’enregistrement du comté de Charlotte le 23 septembre1981, sous le numéro 91236, et par la demande de survivant en-registrée au bureau d’enregistrement foncier le 16 février 2009,sous le numéro 26831496.Avis de vente donné par la Compagnie de fiducie du Groupe In-vestors ltée. La vente aura lieu le 30 avril 2015, à 13 h 15, heurelocale, à l’hôtel de ville de St. Stephen, 73, boulevard Milltown,St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dansles éditions des 1er, 8, 15 et 22 avril 2015 du Telegraph-Journal.

Kathryn L. Stratton, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laCompagnie de fiducie du Groupe Investors ltée, Centre de laCroix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton(Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970,télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataire : Wayne Wilfred Toole, débiteur hypothécaire ori-ginaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au243-245, rue Lutz, à Moncton (Nouveau-Brunswick), et corres-pondant au même lot ayant été transféré à Wayne Wilfred Toolepar l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrementfoncier le 23 juin 2005, sous le numéro 20471075.Avis de vente donné par la Compagnie de fiducie du Groupe In-vestors ltée. La vente aura lieu le 30 avril 2015, à 11 h 15, heurelocale, à l’hôtel de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 1er, 8, 15 et 22 avril 2015 du Times & Transcript.

Kathryn L. Stratton, du cabinet McInnes Cooper, avocats de laCompagnie de fiducie du Groupe Investors ltée, Centre de laCroix Bleue, 644, rue Main, bureau S400, C.P. 1368, Moncton(Nouveau-Brunswick) E1C 8T6, téléphone : 506-857-8970,télécopieur : 506-857-4095

________________

Page 31: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 431 Gazette royale — 15 avril 2015

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Sterling Fairweather, original Mortgagor; and to all otherswhom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgageand the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-ment thereof. Freehold property being situated at 39 ChurchStreet, St. Stephen, New Brunswick, the same lot conveyed toSterling Fairweather by Transfer registered in the Land TitlesOffice on February 26, 2009 as document number 26870221.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held at theSt. Stephen Town Hall located at 73 Milltown Boulevard, Suite112, St. Stephen, New Brunswick, on the 30th day of April,2015, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertisement ofNotice of Sale in the Telegraph-Journal dated April 1, April 8,April 15 and April 22, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Sale of Lands Publication ActR.S.N.B. 1973, c.S-2, s.1(2)

To: Isaac Legere, original Mortgagor; and to all others whom itmay concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage and theProperty Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amendmentthereof. Freehold property being situated at 105 Gordon Street,Moncton, New Brunswick, the same lot conveyed to IsaacLegere by Transfer registered in the Westmorland County Reg-istry Office on July 9, 1999, as document number 668809.

Notice of Sale given by Bank of Montreal. Sale to be held atMoncton City Hall located at 655 Main Street, Moncton, NewBrunswick, on the 30th day of April, 2015, at the hour of 11:00a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in theTimes & Transcript dated April 1, April 8, April 15 and April22, 2015.

McInnes Cooper, Solicitors for Bank of Montreal, Per: AdelGönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite S400, P.O.Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6, Telephone:506-857-8970, Facsimile: 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataire : Sterling Fairweather, débiteur hypothécaire origi-naire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertudes dispositions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi surles biens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au39, rue Church, à St. Stephen (Nouveau-Brunswick), et corres-pondant au même lot ayant été transféré à Sterling Fairweatherpar l’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrementfoncier le 26 février 2009, sous le numéro 26870221.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 30 avril 2015, à 11 h, heure locale, à l’hôtel de ville deSt. Stephen, bureau 112, 73, boulevard Milltown, St. Stephen(Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditionsdes 1er, 8, 15 et 22 avril 2015 du Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rueMain, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annoncesL.R.N.-B. 1973, c.S-2, par.1(2)

Destinataire : Isaac Legere, débiteur hypothécaire originaire; ettout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en vertu des dis-positions de l’acte d’hypothèque et de celles de la Loi sur lesbiens, L.R.N.-B. 1973, c.P-19. Biens en tenure libre situés au105, rue Gordon, à Moncton (Nouveau-Brunswick), et corres-pondant au même lot ayant été transféré à Isaac Legere parl’acte de transfert enregistré au bureau de l’enregistrement ducomté de Westmorland le 9 juillet 1999, sous le numéro668809.Avis de vente donné par la Banque de Montréal. La vente auralieu le 30 avril 2015, à 11 h, heure locale, à l’hôtel de ville deMoncton, situé au 655, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions des1er, 8, 15 et 22 avril 2015 du Times & Transcript.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Banquede Montréal, Centre de la Croix Bleue, bureau S400, 644, rueMain, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

Page 32: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 432 Gazette royale — 15 avril 2015

TO: ALISON LOIS GUIMOND, Mortgagor;

AND TO: CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORA-TION, Mortgagee;AND TO: NICHOLAS JAMES BROWN, Mortgagee;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CON-CERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold property situate at 1002 Mollins Drive, Saint John, Countyof Saint John, Province of New Brunswick and known as ParcelIdentifier Number (PID) 412783.

Notice of Sale is given by the TD Financing Services Home Inc.

The sale is scheduled for Thursday, April 30, 2015, at 11:00a.m., at the Saint John Court House, 10 Peel Plaza, Saint John,New Brunswick.See advertisements in the Telegraph-Journal in the issues ofApril 1, April 8, April 15, and April 22, 2015.Dated this 24th day of March, 2015.

TD FINANCING SERVICES HOME INC., By: LAWSONCREAMER, Per: Veronica L. Ford, Solicitors for TD Fi-nancing Services Home Inc.

________________

TO: DONALD ALLAN TALLIS and JESSICAANGELINA ROYAN, Mortgagor;AND TO: ALL OTHERS TO WHOM IT MAY CON-CERN.Sale conducted under the terms of the first mortgage under theProperty Act, R.S.N.B., 1973, c.P-19, s.44 as amended. Free-hold property situate at 22 Briar Place, Saint John, County ofSaint John, Province of New Brunswick and known as ParcelIdentifier Number (PID) 433029.

Notice of Sale is given by the TORONTO-DOMINION BANK.

The sale is scheduled for Thursday, April 30, 2015, at 11:15a.m., at the Saint John Court House, Peel Plaza, 10 Peel Plaza,Saint John, New Brunswick.See advertisements in the Telegraph-Journal in the issues ofApril 1, April 8, April 15, and April 22, 2015.Dated this 25th day of March, 2015.

THE TORONTO-DOMINION BANK, By: LAWSONCREAMER, Per: VERONICA L. FORD, Solicitors for THETORONTO-DOMINION BANK (TD Canada Trust)

The Royal Gazette is published every Wednesday under theauthority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-ceived by the Royal Gazette Coordinator, LegislativeServices, no later than noon, at least seven days prior toWednesday’s publication. Each document must be separate

Notice to Advertisers

DESTINATAIRES : ALISON LOIS GUIMOND, débiteurhypothécaire;CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST,créancière hypothécaire;NICHOLAS JAMES BROWN, créancier hypothécaire;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 1002, promenadeMollins, à Saint John, comté de Saint John, province duNouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcel-laire est 412783.Avis de vente donné par Services de financement TD résidentielinc. La vente aura lieu le jeudi 30 avril 2015, à 11 h, au palais de jus-tice de Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 1er, 8, 15 et 22 avril2015 du Telegraph-Journal.Fait le 24 mars 2015.

Veronica L. Ford, du cabinet LAWSON CREAMER, avo-cats de SERVICES DE FINANCEMENT TD RÉSIDEN-TIEL INC.

________________

DESTINATAIRES : DONALD ALLAN TALLIS etJESSICA ANGELINA ROYAN, débiteurs hypothécaires;ET TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Vente effectuée en vertu des dispositions du premier acte d’hy-pothèque et de celles de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973,c.P-19, art.44. Biens en tenure libre situés au 22, place Briar, àSaint John, comté de Saint John, province du Nouveau-Brunswick, et dont le numéro d’identification parcellaire est433029.Avis de vente donné par LA BANQUE TORONTO-DOMINION.La vente aura lieu le jeudi 30 avril 2015, à 11 h 15, au palais dejustice de Saint John, 10, place Peel, Saint John (Nouveau-Brunswick).Voir l’annonce publiée dans les éditions des 1er, 8, 15 et 22 avril2015 du Telegraph-Journal.Fait le 25 mars 2015.

VERONICA L. FORD, du cabinet LAWSON CREAMER,avocats de LA BANQUE TORONTO-DOMINION (TDCanada Trust)

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents àpublier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazetteroyale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept joursavant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé

Avis aux annonceurs

Page 33: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 433 Gazette royale — 15 avril 2015

from the covering letter. Signatures on documents must be im-mediately followed by the printed name. The Royal GazetteCoordinator may refuse to publish a document if any part of itis illegible, and may delay publication of any document for ad-ministrative reasons.Prepayment is required for the publication of all documents.Standard documents have the following set fees:

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque ormoney order (payable to the Minister of Finance). No refundswill be issued for cancellations.

The official version of The Royal Gazette is available freeon-line each Wednesday. This free on-line service replaces theprinted annual subscription service. The Royal Gazette can beaccessed on-line at:

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/attorney_general/royal_gazette.html

NoticesCost perInsertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25Order of a court $ 25Notice under the Absconding Debtors Act $ 20Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application forreinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical NursesAct

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of CourtNote: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice isgreater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act(Canada)

$ 20

Notice of a correction charge isthe same as

for publishing the original document

Any other document $3.50 for each cm or less

de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivreimmédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazetteroyale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-ministratives.Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.Voici les tarifs pour les avis courants :

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte decrédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (àl’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement nesera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-tuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit enligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/procureur_general/gazette_royale.html

AvisCoût par parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loid’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $Ordonnance rendue par une cour 25 $Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règlesgénérales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur leBarreau

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières etinfirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour dessuccessions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédureNota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins enlongueur

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voied’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page enlongueur

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur lesliquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les mêmes que ceux imposés

pour la publication du

document original

Tout autre document 3,50 $ pour chaque cm ou

moins

Page 34: The Royal Gazette / Gazette royale (15/04/15) Royal Gazette — April 15, 2015 402 Gazette royale — 15 avril 2015 PROCLAMATION Pursuant to Order in Council 2015-37, I declare that

The Royal Gazette — April 15, 2015 434 Gazette royale — 15 avril 2015

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, atthe following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plusshipping and handling where applicable.

Legislative ServicesOffice of the Attorney General

Chancery Place675 King StreetP.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-8372E-mail: [email protected]

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette andleft with the Commissionaire.

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazetteroyale, à l’adresse suivante, pour la somme de 4 $ l’exem-plaire, plus la taxe de 5 %, ainsi que les frais applicables deport et de manutention.

Services législatifsCabinet du procureur général

Place Chancery675, rue King

C.P. 6000Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-8372Courriel : [email protected]

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doitêtre remise au commissionnaire.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés


Recommended